Actos destacados
Fusión por absorción — 02/03/2018
Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: KRIPSOL EXPORT SL. KRIPSOL PISCINAS SA. KRIPSOL HIDRAULICA SL. KRIPSOL GESTION SL. KRIPSOL IBERICA SL. KRIPSOL ARAGON SL. DITECPOL SL. FIBERPOOL INTERNACIONAL SL. SUGAR VALLE...
Cambio de denominación social — 02/03/2018
Cambio de denominación social. HAYWARD IBERICA SL. Datos registrales. T 1655 , F 224, S 8, H TO 16315, I/A 29 (22.02.18).
Ceses/dimisiones — 22/01/2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH;DAVIS ROBERT MICHAEL. Secretario: DIAMOND ANDREW JOHN. Con.Delegado: HALE CLARK RANDOLPH. Presidente: DAVIS ROBERT MICHAEL. Nombramientos. Adm. Solid....
Otros conceptos: modificación no esencial del proyecto de fusión de fecha 23/06/2017, excluyendo a "kripsol intermark malaga, sl" del perímetro de la fusión y el traslado del domicilio social de "sugar valley, sl", "fiberpool internacional, sl" y "hayward pool acquisition, sl", a yuncos, toledo, calle felipe ii — 28/12/2017
Otros conceptos: Modificación no esencial del proyecto de fusión de fecha 23/06/2017, excluyendo a "KRIPSOL INTERMARK MALAGA, SL" del perímetro de la fusión y el traslado del domicilio social de "SUGAR VALLEY, SL", "FIB...
Revocaciones — 13/02/2017
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL. Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES ALMUDENA. Apo.Manc.: RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Apo.Sol.: LOPEZ BL...
Revocaciones — 19/01/2017
Revocaciones. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1628 , F 191, S 8, H TO 16315, I/A 24 BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 13 Jueves 19 de enero de 2017 Pág. 3115 cve: BORME-A-2017-13-4...
Nombramientos — 19/01/2017
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1628 , F 191, S 8, H TO 16315, I/A 25 (12.01.17).
Ceses/dimisiones — 21/09/2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: JOIMA ALBA SL;PRIMBRAIS SL. Nombramientos. Consejero: DAVIS ROBERT MICHAEL;DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH. Presidente: DAVIS ROBERT MICHAEL. Secretario: DIAMOND ANDREW JOHN. Apo.S...
Revocaciones — 21/09/2016
Revocaciones. Apo.Sol.: ALCAINE ZAPATA ISRAEL;ALMAGRO RECIO ANA MARIA. Apo.Manc.: ALCAINE ZAPATA ISRAEL;ALMAGRO RECIO ANA MARIA. Apo.Man.Soli: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;ALMAGRO RECIO ANA MARIA;ALCAINE ZAPATA ISRAEL. Nombram...
Nombramientos — 21/09/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: GARROFE PUJOL ALBERT;FABREGA RODRIGUEZ-RODA ANNA;SALA CLIMENT MARIA TERESA;BIDAGUREN URBIETA MIREN;RIVERA GARCIA DIANA. Datos registrales. T 1628 , F 190, S 8, H TO 16315, I/A 23 (15.09.16).
Reelecciones — 01/12/2015
Reelecciones. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1500 , F 34, S 8, H TO 16315, I/A 20 (23.11.15).
Ceses/dimisiones — 10/08/2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: JOIMA ALBA SL;PRIMBRAIS SL. Presidente: JOIMA ALBA SL. Secretario: PRIMBRAIS SL. Consejero: DANA GESTION SL. Nombramientos. Adm. Solid.: JOIMA ALBA SL;PRIMBRAIS SL. Modificaciones estatutari...
Ceses/dimisiones — 04/05/2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: REAL SIDI SL. Datos registrales. T 1500 , F 34, S 8, H TO 16315, I/A 18 (23.04.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 82 Lunes 4 de mayo de 2015 Pág. 19527 cve: BORME-A-2015-82-45
Revocaciones — 03/11/2014
Revocaciones. Apo.Manc.: MORO GARRUDO FERNANDO. Apo.Sol.: MORO GARRUDO FERNANDO. Apo.Man.Soli: MORO GARRUDO FERNANDO. Datos registrales. T 1500 , F 34, S 8, H TO 16315, I/A 17 (23.10.14).
Declaración de unipersonalidad — 20/05/2014
Declaración de unipersonalidad. Socio único: KRIPSOL GESTION SL. Cambio de domicilio social. C/ FELIPE II - PARCELA 141. POLIGONO INDUSTRIAL L (YUNCOS). Datos registrales. T 1500 , F 34, S 8, H TO 16315, I/A 16 (12.05.1...
Nombramientos — 20/11/2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;ALMAGRO RECIO ANA MARIA;ALCAINE ZAPATA ISRAEL;MORO GARRUDO FERNANDO. Datos registrales. T 1500 , F 33, S 8, H TO 16315, I/A 15 (11.11.13).
Ceses/dimisiones — 14/10/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALCAINE GIL JESUS MARIA;ALMAGRO SANCHEZ DE PUERTA VICENTE;RECIO PEREZ ANA- MARIA;GARCIA CLAVIJO MANUEL. Presidente: ALCAINE GIL JESUS MARIA. Secretario: GARCIA CLAVIJO MANUEL. Nombramientos....
Nombramientos — 22/03/2013
Nombramientos. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1500 , F 32, S 8, H TO 16315, I/A 13 (14.03.13).
Revocaciones — 04/03/2013
Revocaciones. Apo.Sol.: VAZQUEZ PEREZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 1500 , F 32, S 8, H TO 16315, I/A 12 (25.02.13).
Ceses/dimisiones — 28/06/2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: LEVI ELIO;JIMENEZ ROMERO FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: RECIO PEREZ ANA- MARIA. Reelecciones. Presidente: ALCAINE GIL JESUS MARIA. Secretario: GARCIA CLAVIJO MANUEL. Otros conceptos: M...
Revocaciones — 28/06/2010
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA CLAVIJO MANUEL;RECIO PEREZ ANA-MARIA. Datos registrales. T 1241 , F 166, S 8, H TO 16315, I/A 10 (14.06.10).
Nombramientos — 28/06/2010
Nombramientos. Apo.Sol.: VAZQUEZ PEREZ JOSE RAMON;MORO GARRUDO FERNANDO;ALCAINE ZAPATA ISRAEL;ALMAGRO RECIO ANA MARIA. Apo.Manc.: MORO GARRUDO FERNANDO;ALCAINE ZAPATA ISRAEL;ALMAGRO RECIO ANA MARIA. Datos registrales. T...
Nombramientos — 27/04/2010
Nombramientos. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1241 , F 166, S 8, H TO 16315, I/A 8 (15.04.10).
Ceses/dimisiones — 11/03/2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GARCIA CLAVIJO MANUEL. Revocaciones. Apoderado: ALMAGRO SANCHEZ DE PUERTA VICENTE. Nombramientos. Consejero: ALMAGRO SANCHEZ DE PUERTA VICENTE;ALCAINE GIL JESUS MARIA;LEVI ELIO;JIMENEZ ROME...