Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 12 tarjetas
01/02/2019 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-48457

Nombramientos — 01/02/2019

Nombramientos. Apo.Man.Soli: JIMENEZ LAGUNA JESUS ANGEL. Datos registrales. T 4080 , F 190, S 8, H Z 17043, I/A 31 (24.01.19).

04/01/2019 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-4294

Revocaciones — 04/01/2019

Revocaciones. Apo.Man.Soli: NAVARRO GIMENO MANUEL. Datos registrales. T 4080 , F 190, S 8, H Z 17043, I/A 30 (27.12.18).

29/11/2018 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-480143

Nombramientos — 29/11/2018

Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 4080 , F 189, S 8, H Z 17043, I/A 29 (22.11.18).

23/08/2017 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-345347

Revocaciones — 23/08/2017

Revocaciones. Apoderado: DUMALL HERNANDEZ OLGA. Datos registrales. T 4080 , F 189, S 8, H Z 17043, I/A 27 (11.08.17).

23/08/2017 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-345348

Nombramientos — 23/08/2017

Nombramientos. Apo.Man.Soli: NAVARRO GIMENO MANUEL. Apo.Manc.: JULIAN ALONSO JOSE. Datos registrales. T 4080 , F 189, S 8, H Z 17043, I/A 28 (11.08.17).

20/06/2017 Sec. I Reducción de capital Zaragoza
Zaragoza-255790

Reducción de capital — 20/06/2017

Reducción de capital. Importe reducción: 86.766,37 Euros. Resultante Suscrito: 1.956.633,63 Euros. Datos registrales. T 4080 , F 188, S 8, H Z 17043, I/A 26 (13.06.17).

12/02/2016 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-65375

Nombramientos — 12/02/2016

Nombramientos. Apoderado: DUMALL HERNANDEZ OLGA. Datos registrales. T 4080 , F 187, S 8, H Z 17043, I/A 25 ( 4.02.16).

15/01/2016 Sec. I Modificaciones estatutarias Zaragoza
Zaragoza-16019

Modificaciones estatutarias — 15/01/2016

Modificaciones estatutarias. "ARTICULO 18º.- RETRIBUCION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR.- El cargo de administrador es retribuido, mediante una asignación fija, cuyo importe será aprobado por la junta general y permanecerá...

23/09/2015 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-385807

Nombramientos — 23/09/2015

Nombramientos. Apoderado: JULIAN ALONSO MARIA CARMEN. Datos registrales. T 4080 , F 187, S 8, H Z 17043, I/A 23 (15.09.15).

30/03/2015 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-134486

Revocaciones — 30/03/2015

Revocaciones. Auditor: AUREN AUDITORES ZAZ S.L.P. Datos registrales. T 4080 , F 187, S 8, H Z 17043, I/A 22 (19.03.15).

23/01/2015 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-30709

Nombramientos — 23/01/2015

Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES ZAZ S.L.P. Datos registrales. T 2237 , F 225, S 8, H Z 17043, I/A 21 (14.01.15).

25/02/2011 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-88050

Revocaciones — 25/02/2011

Revocaciones. Auditor: AUREN ZARAGOZA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESI. Datos registrales. T 2237 , F 225, S 8, H Z 17043, I/A 17 (15.02.11).