Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 7 tarjetas
18/12/2019 Sec. I Disolución Madrid
Madrid-524589

Disolución — 18/12/2019

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 32295 , F 225, S 8, H M 581286, I/A 21 (11.12.19). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 241 Miércoles 18 de diciembre de 2019 Pág. 55750 cve: BORME-A-2019-241-2...

28/05/2019 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-226418

Revocaciones — 28/05/2019

Revocaciones. Apoderado: CARCI CERVERA ARMANDO;CARCI CERVERA ARMANDO. Nombramientos. Apoderado: MIGUEL RODRIGUEZ PAULINO. Datos registrales. T 32295 , F 224, S 8, H M 581286, I/A 20 (21.05.19).

22/05/2019 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-217703

Nombramientos — 22/05/2019

Nombramientos. Apo.Sol.: CENTENERA CRESPO IGNACIO;CRUZ-VILLALON GARCIA DIEGO;PAZOS RODRIGUEZ ROMAN;RICHARD HAWRYSCH ENRIQUE;SANCHEZ RODRIGUEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 32295 , F 224, S 8, H M BOLETÍN OFICIAL DEL REG...

03/04/2019 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-149810

Cambio de domicilio social — 03/04/2019

Cambio de domicilio social. C/ VALPORTILLO II, NUMERO 16, POLIGONO INDUSTRIAL (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 32295 , F 224, S 8, H M 581286, I/A 18 (27.03.19).

01/08/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-318422

Revocaciones — 01/08/2018

Revocaciones. Apoderado: GOMEZ GARCIA-ONIEVA ELENA;TORRES FERRER DAGMAR;TORRES FERRER CRISTIAN. Datos registrales. T 32295 , F 224, S 8, H M 581286, I/A 17 (24.07.18).

08/02/2017 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-63167

Revocaciones — 08/02/2017

Revocaciones. Apoderado: WYSONG MICHAEL DAVID;BROUET OLIVIER;DEL NATALE MARIO;DE WAELE JEAN PHILIPPE;VOLTOLINA FRANK ANDREW;LUJAN GERARDO. Nombramientos. Apo.Manc.: DE WAELE JEAN-PHILIPPE MARIE GHISLAIN;BROUET OLIVIER;D...

27/12/2016 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-524405

Reelecciones — 27/12/2016

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32295 , F 222, S 8, H M 581286, I/A 13 (16.12.16).