Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2014 13 tarjetas
30/10/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Cádiz
Cádiz-437142

Ceses/dimisiones — 30/10/2014

Ceses/Dimisiones. Gerente: BAQUERO ALONSO JUAN. SecreNoConsj: PEREZ PEREZ MARIA DEL MILAGRO. Consejero: AGUAS DE JEREZ EMPRESA MUNICIPAL SA;EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE JEREZ SA;EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA...

29/03/2012 Sec. I Nombramientos Cádiz
Cádiz-145609

Nombramientos — 29/03/2012

Nombramientos. Auditor: BARRAL RIVADA ANTONIO. Datos registrales. T 2014 , F 128, S 8, H CA 13838, I/A 31 (16.03.12).

02/02/2012 Sec. I Nombramientos Cádiz
Cádiz-52095

Nombramientos — 02/02/2012

Nombramientos. Presidente: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA. Otros conceptos: Cambio de Repr. físicos de los consejeros : Excmo. Ayto. deJerez Frta. María José García Pelayo Jurado. Jerez Recaudación y Servic...

02/02/2012 Sec. I Nombramientos Cádiz
Cádiz-52096

Nombramientos — 02/02/2012

Nombramientos. Apoderado: ESPINOSA DE LA CALLE ENRIQUE;GARCIA PELAYO JURADO MARIA JOSE. Vicepresid.: JEREZ RECAUDACION Y SERVICIOS SA. Datos registrales. T 2014 , F 127, S 8, H CA 13838, I/A 29 (19.01.12).

02/02/2012 Sec. I Nombramientos Cádiz
Cádiz-52097

Nombramientos — 02/02/2012

Nombramientos. Apoderado: GARCIA PELAYO JURADO MARIA JOSE. Datos registrales. T 2014 , F 127, S 8, H CA 13838, I/A 30 (19.01.12).

18/07/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Cádiz
Cádiz-299892

Ceses/dimisiones — 18/07/2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ MUÑOZ MARIA DEL PILAR. Vicepresid.: SANCHEZ MELLADO CASTO. Consejero: SANCHEZ MELLADO CASTO;RUBIALES BONILLA SEBASTIAN;BARRON FERNANDEZ DE LA PUENTE JAIME. Presidente: SANCHEZ MUÑOZ...

18/07/2011 Sec. I Nombramientos Cádiz
Cádiz-299893

Nombramientos — 18/07/2011

Nombramientos. Presidente: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA. Datos registrales. T 2014 , F 125, S 8, H CA 13838, I/A 25 ( 6.07.11).

18/07/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Cádiz
Cádiz-299894

Ceses/dimisiones — 18/07/2011

Ceses/Dimisiones. Secretario: BAEZ GUZMAN MANUEL. Nombramientos. SecreNoConsj: PEREZ PEREZ MARIA DEL MILAGRO. Datos registrales. T 2014 , F 125, S 8, H CA 13838, I/A 26 ( 6.07.11).

18/07/2011 Sec. I Revocaciones Cádiz
Cádiz-299895

Revocaciones — 18/07/2011

Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ MUÑOZ MARIA DEL PILAR;SANCHEZ MELLADO CASTO. Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ MUÑOZ MARIA DEL PILAR;SANCHEZ MELLADO CASTO. Datos registrales. T 2014 , F 125, S 8, H CA 13838, I/A 27 ( 6...

07/03/2011 Sec. I Modificaciones estatutarias Cádiz
Cádiz-101747

Modificaciones estatutarias — 07/03/2011

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 18.- RESUMEN.ARTICULO 20.- RESUMEN. Cambio de objeto social. la gestión integral de los sistemas informáticos y de la red de comunicaciones del Ayuntamiento de Jerez, de sus Socieda...

02/11/2010 Sec. I Nombramientos Cádiz
Cádiz-403543

Nombramientos — 02/11/2010

Nombramientos. Auditor: HORWATH AUDITORES ESPAÑA SL. Datos registrales. T 1890 , F 199, S 8, H CA 13838, I/A 23 (21.10.10).

16/08/2010 Sec. I Reelecciones Cádiz
Cádiz-320485

Reelecciones — 16/08/2010

Reelecciones. Consejero: FONTAN DEL JUNCO CARLOS;HIDALGO MOTA FRANCISCO;ESPINAR MANCERA ANTONIO;BARCELL ARIZON MANUEL. Datos registrales. T 1890 , F 199, S 8, H CA 13838, I/A 22 ( 5.08.10).

27/11/2009 Sec. I Nombramientos Cádiz
Cádiz-497436

Nombramientos — 27/11/2009

Nombramientos. Auditor: HORWATH AUDITORES ESPAÑA SL. Datos registrales. T 1890 , F 198, S 8, H CA 13838, I/A 21 (18.11.09). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958