Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 13 tarjetas
10/03/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-113779

Nombramientos — 10/03/2016

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SESEÑA SANCHEZ JOSE MARIA;BAÑO SANCHEZ RAUL. Datos registrales. T 29294 , F 101, S 8, H M 452559, I/A 54 ( 3.03.16).

07/04/2015 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-144370

Ampliación de capital — 07/04/2015

Ampliación de capital. Capital: 3.047.080,00 Euros. Resultante Suscrito: 15.006.480,00 Euros. Datos registrales. T 29294 , F 98, S 8, H M 452559, I/A 50 (27.03.15).

05/02/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-53331

Ceses/dimisiones — 05/02/2014

Ceses/Dimisiones. Consejero: DELSO HERAS LUIS;GOMIS CAÑETE JOSE;PORTELA ALVAREZ ANTONIO. Presidente: DELSO HERAS LUIS. Vicepresid.: GOMIS CAÑETE JOSE. Con.Delegado: PORTELA ALVAREZ ANTONIO. Consejero: VARELA ULLASTRES S...

05/02/2014 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-53332

Ampliación de capital — 05/02/2014

Ampliación de capital. Capital: 6.500.300,00 Euros. Resultante Suscrito: 11.959.400,00 Euros. Datos registrales. T 29294 , F 96, S BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 24 Miércoles 5 de febrero de 2014 Pág. 5670...

07/10/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-428818

Revocaciones — 07/10/2013

Revocaciones. Apoderado: RUIZ DE CASTAÑEDA RODRIGUEZ HENAR. Datos registrales. T 29294 , F 96, S 8, H M 452559, I/A 44 (30.09.13).

17/06/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-276200

Nombramientos — 17/06/2013

Nombramientos. Apoderado: MARTIN CASTELLO FELIX. Datos registrales. T 29294 , F 95, S 8, H M 452559, I/A 43 ( 7.06.13).

01/02/2013 Sec. I Cambio de objeto social Madrid
Madrid-50984

Cambio de objeto social — 01/02/2013

Cambio de objeto social. LA GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL MEIDANTE LA CORRESPONDIENTE ORGANIZACION DE MEDIOS MATERIALES Y PERS...

27/08/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-355407

Nombramientos — 27/08/2012

Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;DE EGAÑA HUERTA ALFONSO MIGUEL;DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO. Apo.Man.Soli: RODERA TOBAL ANA PALOMA. Apo.Manc.: GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN;PIR...

01/07/2011 Sec. I Sociedad unipersonal Madrid
Madrid-278800

Sociedad unipersonal — 01/07/2011

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: NUEVA GRUPO ISOLUX CORSAN CONCESIONES SL. Datos registrales. T 25213 , F 222, S 8, H M 452559, I/A 28 (15.06.11).

27/07/2010 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-294466

Nombramientos — 27/07/2010

Nombramientos. Apoderado: LABARRA BLANCO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 25213 , F 218, S 8, H M 452559, I/A 23 (15.07.10).

26/02/2010 Sec. I Sociedad unipersonal Madrid
Madrid-83914

Sociedad unipersonal — 26/02/2010

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: GRUPO ISOLUX CORSAN CONCESIONES SL. Datos registrales. T 25213 , F 197, S 8, H M 452559, I/A 16 (16.02.10). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 39 Viern...

17/02/2010 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-68776

Revocaciones — 17/02/2010

Revocaciones. Apoderado: MESEGUER VELASCO JOSE LUIS;HERNANDEZ NUÑEZ ANTONIO. Datos registrales. T 25213 , F 196, S 8, H M 452559, I/A 15 ( 8.02.10).

07/01/2010 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-5070

Nombramientos — 07/01/2010

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO. Datos registrales. T 25213 , F 193, S 8, H M 452559, I/A 13 (23.12.09).