Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2015 5 tarjetas
15/01/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-14198

Ceses/dimisiones — 15/01/2015

Ceses/Dimisiones. Secretario: SEGURA BULDU JUAN. Consejero: HARDING CARLOS GUILLERMO;TRUCHOT DIDIER. Presidente: HARDING CARLOS GUILLERMO. Vicepresid.: TRUCHOT DIDIER. Consejero: COSTA ARGELAGUET FRANCESC. Con.Delegado:...

08/07/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-280834

Nombramientos — 08/07/2014

Nombramientos. Apoderado: SARTORIUS ALVARGONZALEZ ALVARO;HERNANDO DOMINGO ANTONIO;SEIJO FONT JUAN ANTONIO;CALDEIRO ZAMORA JESUS. Datos registrales. T 15648 , F 210, S 8, H M 54188, I/A 55 (30.06.14).

27/12/2013 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-554257

Cambio de domicilio social — 27/12/2013

Cambio de domicilio social. AVDA LLANO CASTELLANO 13 3º A (MADRID). Datos registrales. T 15648 , F 209, S 8, H M 54188, I/A 53 (18.12.13).

05/12/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-521538

Nombramientos — 05/12/2013

Nombramientos. Apo.Sol.: URBINA GOMEZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 15648 , F 208, S 8, H M 54188, I/A 52 (27.11.13).

14/10/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-438582

Revocaciones — 14/10/2013

Revocaciones. Apoderado: DE LAS NAVAS DEL AMO VICTOR ARTURO. Datos registrales. T 15648 , F 208, S 8, H M 54188, I/A 51 ( 4.10.13).