Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 15 tarjetas
26/12/2019 Sec. I Cambio de denominación social Madrid
Madrid-538180

Cambio de denominación social — 26/12/2019

Cambio de denominación social. SANTANDER FACILITY MANAGEMENT ESPAÑA SL. Cambio de objeto social. SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION INTEGRAL URBANISTICA E INMOBILIARIA, ASESORAR, DOCUMENTAR Y GESTIONAR PROYECTOS, I...

29/11/2019 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-495063

Nombramientos — 29/11/2019

Nombramientos. Apoderado: GARCIA LOPEZ GABRIEL JOSE;BROTON CORTES ANGEL. Datos registrales. T 33971 , F 24, S 8, H M 203422, I/A 38 (22.11.19).

14/11/2019 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-471454

Revocaciones — 14/11/2019

Revocaciones. Apo.Manc.: BABIO MARTIN GERARDO;DE LA CRUZ MARCHANTE ALFONSO;MARIN GOVANTES FRANCISCO. Datos registrales. T 33971 , F 23, S 8, H M 203422, I/A 37 ( 7.11.19).

23/05/2019 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-220692

Revocaciones — 23/05/2019

Revocaciones. Apo.Manc.: ALFONSO PUERTAS JAIME JUAN. Apoderado: RON GUIMIL ANGEL. Datos registrales. T 33971 , F 23, S 8, H M 203422, I/A 36 (16.05.19).

03/10/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-397515

Revocaciones — 03/10/2018

Revocaciones. Apo.Manc.: FERNANDEZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN;GARCIA POZO FRANCISCO JAVIER;JIMENEZ MARTIN FERNANDO;GUZMAN DIAZ SILVIA;PARDO GARCIA JOSE;MARTIN SAEZ PATRICIA;OTERO BLANCO JOSE MARCOS;LOPEZ MEJIAS JESUS MIGUEL...

20/08/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-342963

Nombramientos — 20/08/2018

Nombramientos. Apoderado: GESBAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GLOBALES SL. Datos registrales. T 33971 , F 21, S 8, H M 203422, I/A 33 ( 9.08.18).

23/07/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-303953

Ceses/dimisiones — 23/07/2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: SAENZ GARCIA JOSE MANUEL;PARDO GARCIA JOSE;JIMENEZ JUAREZ PABLO. Presidente: SAENZ GARCIA JOSE MANUEL. SecreNoConsj: CAAMAÑO LOPEZ MARIA-CARMEN. VsecrNoConsj: RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO J...

26/07/2017 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-307168

Revocaciones — 26/07/2017

Revocaciones. Apo.Sol.: HERNANDO TUNDIDOR JULIO-CESAR. Datos registrales. T 33971 , F 20, S 8, H M 203422, I/A 30 (18.07.17).

23/05/2017 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-213256

Revocaciones — 23/05/2017

Revocaciones. Apoderado: PEREIRA PENA TOMAS. Datos registrales. T 33971 , F 19, S 8, H M 203422, I/A 28 (16.05.17).

18/05/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-206033

Nombramientos — 18/05/2017

Nombramientos. Apoderado: CARBAJOSA VICENTE JORGE. Datos registrales. T 33971 , F 18, S 8, H M 203422, I/A 26 (10.05.17).

18/05/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-206034

Nombramientos — 18/05/2017

Nombramientos. Apoderado: TIERRA MERINERO JOSE LUIS. Datos registrales. T 33971 , F 19, S 8, H M 203422, I/A 27 (10.05.17).

07/04/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-157440

Ceses/dimisiones — 07/04/2017

Ceses/Dimisiones. Consejero: MOHEDANO GOMEZ LUIS. Presidente: MOHEDANO GOMEZ LUIS. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ JUAREZ PABLO. Presidente: SAENZ GARCIA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 33971 , F 18, S 8, H M 203422...

30/10/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-438384

Nombramientos — 30/10/2015

Nombramientos. Apo.Manc.: FERNANDEZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN;GARCIA POZO FRANCISCO JAVIER;JIMENEZ MARTIN FERNANDO;GUZMAN DIAZ SILVIA;PARDO GARCIA JOSE;MARTIN SAEZ PATRICIA;OTERO BLANCO JOSE MARCOS;LOPEZ MEJIAS JESUS MIGUE...

30/10/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-438385

Revocaciones — 30/10/2015

Revocaciones. Apo.Manc.: BABIO MARTIN GERARDO;FERNANDEZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN;GARCIA POZO FRANCISCO JAVIER;JIMENEZ MARTIN FERNANDO;GARCIA SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES;GUZMAN DIAZ SILVIA;FUENTES LORO YOLANDA;PARDO GARCI...

27/07/2011 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-312184

Ampliación de capital — 27/07/2011

Ampliación de capital. Capital: 27.606.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 72.701.100,00 Euros. Datos registrales. T 20301 , F 190, S 8, H M 203422, I/A 18 (15.07.11).