Actos destacados
Nombramientos — 27/12/2019
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3648 , F 147, S 8, H TF 39010, I/A 42 ( 3.12.19).
Revocaciones — 03/12/2019
Revocaciones. Apo.Manc.: DOLS COMPANY MARIA DEL PILAR;RAMIS ARROM CATALINA;DE LA HERA SALVADOR JUAN;BERMUDEZ ARA MIGUEL;TAPIA MORENO RAQUEL;GONZALEZ SANTOLAYA LUIS CARLOS;VERA SANCHEZ ANTONIO JOSE. Nombramientos. Apo.Ma...
Revocaciones — 14/06/2019
Revocaciones. Apo.Sol.: RAMOS GIMENEZ OSCAR;SERVERA ANDREU ONOFRE. Datos registrales. T 3293 , F 169, S 8, H TF 39010, I/A 40 ( 4.06.19).
Nombramientos — 23/04/2019
Nombramientos. Apo.Manc.: AZZAM FARIS SAAD;DAUDEN RODRIGUEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 3293 , F 169, S 8, H TF 39010, I/A 39 ( 8.04.19).
Revocaciones — 04/10/2018
Revocaciones. Apo.Manc.: FERRERES ANORO MIGUEL;FORERO SEPULVEDA PAULA;ACEVEDO FERNANDEZ JOSE DAVID;DAUDEN RODRIGUEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 3293 , F 168, S 8, H TF 39010, I/A 38 (21.09.18).
Revocaciones — 13/11/2017
Revocaciones. Apo.Manc.: FERRERES ANORO MIGUEL;RODRIGUEZ NIETO ANGEL;ACEVEDO FERNANDEZ JOSE DAVID;DAUDEN RODRIGUEZ ENRIQUE. Nombramientos. Apo.Manc.: FERRERES ANORO MIGUEL;FORERO SEPULVEDA PAULA;ACEVEDO FERNANDEZ JOSE D...
Nombramientos — 21/04/2017
Nombramientos. Apo.Manc.: FERRERES ANORO MIGUEL;RODRIGUEZ NIETO ANGEL;ACEVEDO FERNANDEZ JOSE DAVID;DAUDEN RODRIGUEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 3293 , F 168, S 8, H TF 39010, I/A 36 ( 7.04.17).
Revocaciones — 30/03/2017
Revocaciones. Apo.Manc.: SERVERA ANDREU ONOFRE;RAMIS ARROM CATALINA;RAMIS PLANAS ANTONIO;BERMUDEZ ARA MIGUEL;HODDINOTT MARK MAURICE;DOLS COMPANY MARIA DEL PILAR;GONZALEZ SANTOLAYA LUIS CARLOS;VERA SANCHEZ ANTONIO JOSE....
Revocaciones — 25/01/2017
Revocaciones. Apoderado: RAMOS GIMENEZ OSCAR. Datos registrales. T 3293 , F 167, S 8, H TF 39010, I/A 33 (17.01.17).
Revocaciones — 25/01/2017
Revocaciones. Apo.Manc.: FERRES ANORO MIGUEL;RODRIGUEZ NIETO ANGEL;ACEVEDO FERNANDEZ JOSE DAVID;FITOR REUS JUAN CARLOS. Datos registrales. T 3293 , F 167, S 8, H TF 39010, I/A 34 (17.01.17).
Reelecciones — 07/11/2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3293 , F 167, S 8, H TF 39010, I/A 32 (21.10.16).
Cambio de objeto social — 26/10/2016
Cambio de objeto social. La sociedad tendrá por objeto, tanto en España como fuera de ella, por cuenta propia y ajena: 1. La promoción, explotación, gestión, administración, compraventa y arrendamiento de toda clase de...
Ceses/dimisiones — 16/07/2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: HODDINOTT MARK MAURICE. Vicepresid.: HODDINOTT MARK MAURICE. SecreNoConsj: PELAYO MUÑOZ TOMAS. Reelecciones. Consejero: ESCARRER JAUME GABRIEL. Presidente: ESCARRER JAUME GABRIEL. Datos regi...
Ampliación de capital — 16/04/2014
Ampliación de capital. Suscrito: 40.000.000,00 Euros. Desembolsado: 40.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 51.766.600,00 Euros. Resultante Desembolsado: 51.766.600,00 Euros. Otros conceptos: Se modifica el valor nomi...
Ceses/dimisiones — 03/04/2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: T.I. PARTICIPACIONES SL;FONOMED GESTION TELEFONICA MEDITERRANEO S.A. Vicepresid.: T.I. PARTICIPACIONES SL. Nombramientos. Consejero: GERONDEAU ANDRE PHILIPPE. Vicepresid.: HODDINOTT MARK MAU...
Reducción de capital — 23/12/2013
Reducción de capital. Importe reducción: 20.918.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 11.766.600,00 Euros. Datos registrales. T 3242 , F 44, S 8, H TF 39010, I/A 25 (20.11.13).
Reelecciones — 14/10/2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3242 , F 44, S 8, H TF 39010, I/A 24 ( 3.10.13).
Adaptación de sociedad — 04/10/2013
Adaptación de sociedad. Otros conceptos: Adaptación de los estatutos sociales a la Ley de Sociedades de Capital. Datos registrales. T 3242 , F 41, S 8, H TF 39010, I/A 23 (19.09.13). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANT...
Ceses/dimisiones — 09/07/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: SERVERA ANDREU ONOFRE. Nombramientos. Consejero: HODDINOTT MARK MAURICE. Datos registrales. T 3242 , F 40, S 8, H TF 39010, I/A 22 (15.06.13).
Nombramientos — 31/08/2012
Nombramientos. Consejero: SERVERA ANDREU ONOFRE. Reelecciones. Consejero: T.I. PARTICIPACIONES SL. Vicepresid.: T.I. PARTICIPACIONES SL. Cambio de domicilio social. AVDA LOS OCEANOS S/N - HOTEL PALACIO DE ISORA, ALC (SA...
Ceses/dimisiones — 31/05/2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ ABREU CARMELO. Datos registrales. T 2809 , F 123, S 8, H TF 39010, I/A 15 (21.05.12).
Nombramientos — 31/05/2012
Nombramientos. Apoderado: RAMOS GIMENEZ OSCAR. Datos registrales. T 2809 , F 123, S 8, H TF 39010, I/A 16 (21.05.12).
Nombramientos — 31/05/2012
Nombramientos. Apo.Sol.: RAMOS GIMENEZ OSCAR;SERVERA ANDREU ONOFRE. Datos registrales. T 2809 , F 123, S 8, H TF 39010, I/A 17 (21.05.12).
Reelecciones — 03/08/2011
Reelecciones. Consejero: PEREZ ABREU CARMELO. Datos registrales. T 2809 , F 122, S 8, H TF 39010, I/A 13 (19.07.11).