Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2017 6 tarjetas
27/03/2017 Sec. I Disolución Pontevedra
Pontevedra-137399

Disolución — 27/03/2017

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 2687, L 2687, F 50, S 8, H PO 29659, I/A 8 (16.03.17).

23/06/2015 Sec. I Revocaciones Pontevedra
Pontevedra-257662

Revocaciones — 23/06/2015

Revocaciones. Auditor: AB. AUDASO SL. Datos registrales. T 2687, L 2687, F 49, S 8, H PO 29659, I/A 7 (15.06.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 116 Martes 23 de junio de 2015 Pág. 27817 cve: BORME-A-2015-1...

23/03/2015 Sec. I Nombramientos Pontevedra
Pontevedra-122988

Nombramientos — 23/03/2015

Nombramientos. Apoderado: PUENTE GOMEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 2687, L 2687, F 49, S 8, H PO 29659, I/A 6 (12.03.15).

19/12/2014 Sec. I Nombramientos Pontevedra
Pontevedra-519213

Nombramientos — 19/12/2014

Nombramientos. Auditor: AB. AUDASO SL. Datos registrales. T 2687, L 2687, F 48, S 8, H PO 29659, I/A 5 ( 9.12.14).

15/02/2012 Sec. I Cambio de domicilio social Pontevedra
Pontevedra-76163

Cambio de domicilio social — 15/02/2012

Cambio de domicilio social. AVDA ALCALDE GREGORIO ESPINO 34 (VIGO). Datos registrales. T 2687, L 2687, F 47, S 8, H PO 29659, I/A 3 ( 3.02.12).

15/02/2012 Sec. I Nombramientos Pontevedra
Pontevedra-76164

Nombramientos — 15/02/2012

Nombramientos. Apoderado: GOMEZ FORTES DORINDA. Datos registrales. T 2687, L 2687, F 47, S 8, H PO 29659, I/A 4 ( 3.02.12).