Actos destacados
Nombramientos — 05/09/2016
Nombramientos. Apoderado: OCHOA LARRINGAN ANTONIO. Datos registrales. T 2751 , F 184, S 8, H SS 27370, I/A 39 (23.08.16).
Nombramientos — 22/06/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: GESLICO GESTION DE COBROS SA. Datos registrales. T 2699 , F 76, S 8, H SS 27370, I/A 32 (14.06.16).
Nombramientos — 22/06/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: EGUSQUIZA GONZALEZ GIL JULIO;ALONSO SANCHEZ PEDRO;COBA DIEGUEZ DANIEL. Datos registrales. T 2699 , F 76, S 8, H SS 27370, I/A 33 (14.06.16).
Nombramientos — 22/06/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: TECNOTRAMIT GESTION SL. Datos registrales. T 2699 , F 78, S 8, H SS 27370, I/A 34 (14.06.16).
Nombramientos — 22/06/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL. Datos registrales. T 2699 , F 79, S 8, H SS 27370, I/A 35 (14.06.16).
Nombramientos — 22/06/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: MORA GARCIA RAFAEL;MORENO MORENO JUAN FRANCISCO;IBAÑEZ SEGURA ALFONSO;MARTIN GARCIA MARIANO;RUIZ PEREZ FRANCISCO JOSE;CARRETERO AVIA SONIA;ALVAREZ SERRANO M. CARMEN;GOMEZ MARTIN ANDRES;URCELAY R...
Nombramientos — 22/06/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: CARRILLO MARTINEZ MONTSE;ONA VIDAL SERGIO;LURI IBORRA HELENA MARIA;PALAZON DE LA BARREDA JOSE MARTIN;LORENZO RODRIGUEZ JAVIER;PEREZ RODRIGUEZ DEL VALLE MARIA DEL CARMEN;PALAZON ARMAS MIRIAM;GONZ...
Nombramientos — 22/06/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: PENAS LOPEZ JOSE IGNACIO;LOPEZ CABADO LUIS MIGUEL;LOPEZ VAZQUEZ JOSE MANUEL;BOADO PEDRIDO ALBERTO;VAZQUEZ VIDAL CARLOS;VEIGA BOUZA RAFAEL;PRADA SOMOZA JOSE CARLOS;DIAZ VILLAR JOSE ANGEL;ALVAREZ...
Revocaciones — 02/06/2016
Revocaciones. Apo.Sol.: RAMIREZ ARAMENDIA RAFAEL. Datos registrales. T 2699 , F 76, S 8, H SS 27370, I/A 31 (23.05.16).
Modificación de poderes — 25/04/2016
Modificación de poderes. Apoderado: LION ASSETS HOLDING COMPANY SL. Datos registrales. T 2699 , F 75, S 8, H SS 27370, I/A 30 (14.04.16).
Nombramientos — 15/02/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: PARRA ESPEJO JAVIER;BAJO PRADOS MARIA EUGENIA. Datos registrales. T 2699 , F 73, S 8, H SS 27370, I/A 26 ( 2.02.16).
Nombramientos — 15/02/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL. Datos registrales. T 2699 , F 74, S 8, H SS 27370, I/A 27 ( 2.02.16).
Nombramientos — 15/02/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: TOÑA DUCAR GONZALO. Datos registrales. T 2699 , F 74, S 8, H SS 27370, I/A 28 ( 2.02.16).
Nombramientos — 15/02/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: ZERDAN FERREIRA GONZALO;DEL CAMPO RODRIGUEZ MARTA;CARBAJAL LABRADOR JESUS;MARQUEZ RAMIREZ NATALIA MARIA;RUIZ MURES ALICIA;GUILLENA SOSA MARIA GRACIA;GONZALEZ PEÑA PALOMA;DE LA ORDEN NAVEIRAS LUI...
Nombramientos — 11/12/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: COBA DIEGUEZ DANIEL. Datos registrales. T 2699 , F 69, S 8, H SS 27370, I/A 20 (30.11.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 236 Viernes 11 de diciembre de 2015 Pág. 54126 cve: BORME-A...
Nombramientos — 11/12/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: EGUSQUIZA GONZALEZ GIL JULIO. Datos registrales. T 2699 , F 70, S 8, H SS 27370, I/A 21 (30.11.15).
Nombramientos — 11/12/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: ABALOS GARCIA DANIEL. Datos registrales. T 2699 , F 71, S 8, H SS 27370, I/A 22 ( 1.12.15).
Nombramientos — 11/12/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: NICOLAU FRANCO JOSE LUIS. Datos registrales. T 2699 , F 71, S 8, H SS 27370, I/A 23 ( 1.12.15).
Nombramientos — 11/12/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: OLABARRI GORTAZAR RAFAEL. Datos registrales. T 2699 , F 72, S 8, H SS 27370, I/A 24 ( 1.12.15).
Nombramientos — 11/12/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: RAMIREZ ARAMENDIA RAFAEL. Datos registrales. T 2699 , F 73, S 8, H SS 27370, I/A 25 ( 1.12.15).
Nombramientos — 04/12/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO SANCHEZ PEDRO. Datos registrales. T 2699 , F 69, S 8, H SS 27370, I/A 19 (30.11.15).
Revocaciones — 11/11/2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: FUENTES MARTIN JOSE MANUEL. Apoderado: MUNDUATE AUZMENDI IÑAKI. Nombramientos. Apo.Sol.: IGLESIAS LEZAMA JOSE IGNACIO;BERRUEZO ALZUETA JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 2699 , F 67, S 8, H SS...
Cambio de domicilio social — 11/11/2015
Cambio de domicilio social. C/ BERGARA 14 1º A (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN). Datos registrales. T 2699 , F 69, S 8, H SS 27370, I/A 18 ( 3.11.15).
Ampliación de capital — 04/08/2015
Ampliación de capital. Capital: 17.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 17.003.010,00 Euros. Reducción de capital. Importe reducción: 10.201.806,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.801.204,00 Euros. Datos registrales. T...