Actos destacados
Nombramientos — 05/09/2016
Nombramientos. Apoderado: OCHOA LARRINGAN ANTONIO. Datos registrales. T 2751 , F 97, S 8, H SS 27360, I/A 39 (23.08.16).
Nombramientos — 22/06/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: GESLICO GESTION DE COBROS SA. Datos registrales. T 2699 , F 61, S 8, H SS 27360, I/A 32 BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 118 Miércoles 22 de junio de 2016 Pág. 28488 cve: BORME-A-2016...
Nombramientos — 22/06/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: EGUSQUIZA GONZALEZ GIL JULIO;ALONSO SANCHEZ PEDRO;COBA DIEGUEZ DANIEL. Datos registrales. T 2699 , F 62, S 8, H SS 27360, I/A 33 (10.06.16).
Nombramientos — 22/06/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: TECNOTRAMIT GESTION SL. Datos registrales. T 2699 , F 63, S 8, H SS 27360, I/A 34 (10.06.16).
Nombramientos — 22/06/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL. Datos registrales. T 2699 , F 64, S 8, H SS 27360, I/A 35 (10.06.16).
Nombramientos — 22/06/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: MORA GARCIA RAFAEL;MORENO MORENO JUAN FRANCISCO;IBAÑEZ SEGURA ALFONSO;MARTIN GARCIA MARIANO;RUIZ PEREZ FRANCISCO JOSE;CARRETERO AVIA SONIA;ALVAREZ SERRANO M. CARMEN;GOMEZ MARTIN ANDRES;URCELAY R...
Nombramientos — 22/06/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ ZURRON JOSE MIGUEL;GONZALEZ ANDRINO NADIA;PULPON CHAMORRO PATRICIA;PACIOS ROBLES AZUCENA;RUIZ DE GRADO JAVIER;MARTINEZ MARTINEZ NORVELLYS;FAURA FERNANDEZ JOSE LUIS;RODRIGUEZ ZAYAS FRAN...
Nombramientos — 22/06/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: MENAYA NIETO-ALISEDA PABLO;PIZARRO TORERS JOSE MARIA;CONDE PRADILLO FERNANDO;PERERA COMERON AMALIA;ROJAS ALONSO PABLO;DURAN CERRADA MANUEL;HOLGUERA MEJIAS JOAQUIN;FORTUNY ESBERT FREDERIC;CARDONA...
Revocaciones — 02/06/2016
Revocaciones. Apo.Sol.: RAMIREZ ARAMENDIA RAFAEL. Datos registrales. T 2699 , F 61, S 8, H SS 27360, I/A 31 (23.05.16).
Modificación de poderes — 25/04/2016
Modificación de poderes. Apoderado: LION ASSETS HOLDING COMPANY SL. Datos registrales. T 2699 , F 60, S 8, H SS 27360, I/A 30 (14.04.16).
Nombramientos — 30/03/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: PARRA ESPEJO JAVIER;BAJO PRADOS MARIA EUGENIA. Datos registrales. T 2699 , F 58, S 8, H SS 27360, I/A 26 (21.03.16).
Nombramientos — 30/03/2016
Nombramientos. Apoderado: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL. Datos registrales. T 2699 , F 59, S 8, H SS 27360, I/A 27 (21.03.16).
Nombramientos — 30/03/2016
Nombramientos. Apoderado: TOÑA DUCAR GONZALO. Datos registrales. T 2699 , F 59, S 8, H SS 27360, I/A 28 (21.03.16).
Nombramientos — 30/03/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: ZERDAN FERREIRA GONZALO;DEL CAMPO RODRIGUEZ MARTA;CARBAJAL LABRADOR JESUS;DUGO CADENAS DE LLANO FERNANDO;PERTUSA OLASCOAGA LIBE;LOPEZ GARCIA MENDOZA MERCEDES;ESCOBAR OBRERO MIGUEL ANGEL;HERNANZ...
Nombramientos — 11/12/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: COBA DIEGUEZ DANIEL. Datos registrales. T 2699 , F 54, S 8, H SS 27360, I/A 20 (30.11.15).
Nombramientos — 11/12/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: EGUSQUIZA GONZALEZ GIL JULIO. Datos registrales. T 2699 , F 55, S 8, H SS 27360, I/A 21 (30.11.15).
Nombramientos — 11/12/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: ABALOS GARCIA DANIEL. Datos registrales. T 2699 , F 56, S 8, H SS 27360, I/A 22 ( 1.12.15).
Nombramientos — 11/12/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: NICOLAU FRANCO JOSE LUIS. Datos registrales. T 2699 , F 56, S 8, H SS 27360, I/A 23 ( 1.12.15).
Nombramientos — 11/12/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: OLABARRI GORTAZAR RAFAEL. Datos registrales. T 2699 , F 57, S 8, H SS 27360, I/A 24 ( 1.12.15).
Nombramientos — 11/12/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: RAMIREZ ARAMENDIA RAFAEL. Datos registrales. T 2699 , F 58, S 8, H SS 27360, I/A 25 ( 1.12.15).
Nombramientos — 04/12/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO SANCHEZ PEDRO. Datos registrales. T 2699 , F 54, S 8, H SS 27360, I/A 19 (30.11.15).
Cambio de domicilio social — 11/11/2015
Cambio de domicilio social. C/ BERGARA, Nº14-1ºA. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN). Datos registrales. T 2699 , F 52, S 8, H SS 27360, I/A 17 ( 3.11.15).
Revocaciones — 11/11/2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: FUENTES MARTIN JOSE MANUEL;MUNDUATE AUZMENDI IÑAKI. Nombramientos. Apo.Sol.: IGLESIAS LEZAMA JOSE IGNACIO;BERRUEZO ALZUETA JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 2699 , F 52, S 8, H SS 27360, I/A...
Ampliación de capital — 04/08/2015
Ampliación de capital. Capital: 16.800.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 16.815.000,00 Euros. Reducción de capital. Importe reducción: 12.611.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.203.750,00 Euros. Datos registrales. T...