Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 4 tarjetas
01/03/2019 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-97352

Revocaciones — 01/03/2019

Revocaciones. Apoderado: COBAS ALVAREZ JOSE. Apo.Manc.: COBAS GONZALEZ JOSE ANTONIO;RODRIGUEZ SERANTES RICARDO. Nombramientos. Apoderado: MENDIZABAL PEREZ ROBERTO DELFIN. Datos registrales. T 31529 , F 185, S 8, H M 567...

31/05/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-226610

Ceses/dimisiones — 31/05/2017

Ceses/Dimisiones. Consejero: CASTRO MONTENEGRO PATRICIA. Vicepresid.: REY CAMBA PILAR. Consejero: REY CAMBA PILAR. Reelecciones. Consejero: CASTRO REY FATIMA. Con.Delegado: CASTRO MONTENEGRO MARTA. Presidente: MONTENEGR...

23/08/2013 Sec. I Nombramientos Pontevedra
Pontevedra-375279

Nombramientos — 23/08/2013

Nombramientos. Apo.Sol.: MONTENEGRO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN;CATRO RODRIGUEZ EMILIO. Datos registrales. T 1326, L 1326, F 135, S 8, H PO 9803, I/A 34 (13.08.13).

24/08/2012 Sec. I Cancelaciones de oficio de nombramientos Pontevedra
Pontevedra-354318

Cancelaciones de oficio de nombramientos — 24/08/2012

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: MONTENEGRO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN. Presidente: BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 162 Viernes 24 de agosto de 2012 Pág. 38662 cve: BORME-A-2012-162-36 MON...