Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2017 6 tarjetas
11/04/2017 Sec. I Cambio de denominación social Madrid
Madrid-161595

Cambio de denominación social — 11/04/2017

Cambio de denominación social. TORRE DE CERES SL. Datos registrales. T 8246 , F 221, S 8, H M 133010, I/A 29 ( 4.04.17).

07/02/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-60648

Nombramientos — 07/02/2017

Nombramientos. Apoderado: DOMECQ SOLIS MIGUEL. Datos registrales. T 8246 , F 221, S 8, H M 133010, I/A 28 (26.01.17).

27/12/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-524145

Revocaciones — 27/12/2016

Revocaciones. Apoderado: ROYAN SERRANO ALFONSO;LOPEZ GARCIA ANA MARIA. Apo.Man.Soli: BAZAN NAVARRO ANASTASIO;DOMECQ SOLIS RAFAEL;GARCIA BELLO SANDRA;RIVAS LLANDERAS ADORACION. Nombramientos. Apoderado: CAÑEDO-ARGUELLES...

20/11/2015 Sec. I Fusión por absorción Madrid
Madrid-470334

Fusión por absorción — 20/11/2015

Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: TORRE DE CERES SL. Datos registrales. T 8246 , F 217, S 8, H M 133010, I/A 25 (13.11.15). 470335 - SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA...

08/01/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-4200

Revocaciones — 08/01/2015

Revocaciones. Apo.Man.Soli: DOMECQ SOLIS MIGUEL;BOBO IBAÑEZ MARIANO;CAÑEDO-ARGUELLES OSBORNE GONZALO;BAZAN NAVARRO ANASTASIO;DOMECQ SOLIS RAFAEL;DOMECQ YBARRA CRISTINA;GOMEZ BRUÑO AMAYA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BAZ...

19/04/2012 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-173892

Ampliación de capital — 19/04/2012

Ampliación de capital. Capital: 650.003,13 Euros. Resultante Suscrito: 2.991.577,05 Euros. Datos registrales. T 8246 , F 210, S 8, H M 133010, I/A 18 ( 9.04.12).