Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2015 15 tarjetas
04/03/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Lleida
Lleida-94719

Ceses/dimisiones — 04/03/2015

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DANVIA 58 SL. Liquidador: GIMENO BORRAS JOSE MARIA. Socio único: DANVIA 58 SL. Revocaciones. Apoderado: GIMENO BORRAS JOSE MARIA;BRIAS GONZALEZ MARIA MONTSERRAT;CARRILLO BERMUDEZ ANTONIO;CA...

29/01/2015 Sec. I Nombramientos Lleida
Lleida-39673

Nombramientos — 29/01/2015

Nombramientos. Apoderado: GIMENO BRIAS DANIEL. Datos registrales. T 1240 , F 52, S 8, H L 24384, I/A 22 (16.01.15).

08/01/2015 Sec. I Revocaciones Lleida
Lleida-4094

Revocaciones — 08/01/2015

Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ MONTERDE RAFAEL. Otros conceptos: Subsanan la escritura que motivó la inscripción 20& del historial de la sociedad. Datos registrales. T 1240 , F 52, S 8, H L 24384, I/A 21 (24.12.14).

12/11/2014 Sec. I Revocaciones Lleida
Lleida-457519

Revocaciones — 12/11/2014

Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ MONTERDE RAFAEL. Datos registrales. T 1240 , F 52, S 8, H L 24384, I/A 20 ( 4.11.14).

11/11/2014 Sec. I Nombramientos Lleida
Lleida-455267

Nombramientos — 11/11/2014

Nombramientos. Apoderado: BRIAS GONZALEZ MARIA MONTSERRAT. Datos registrales. T 1228 , F 158, S 8, H L 24384, I/A 19 (22.10.14).

02/07/2014 Sec. I Revocaciones Lleida
Lleida-272934

Revocaciones — 02/07/2014

Revocaciones. Apo.Manc.: MORALES TRESCENTS XAVIER;SALGADO MORA MARCELINO. Datos registrales. T 1228 , F 158, S 8, H L 24384, I/A 18 (18.06.14).

18/10/2012 Sec. I Revocaciones Lleida
Lleida-423809

Revocaciones — 18/10/2012

Revocaciones. Apoderado: DUCH SOLE MONTSERRAT. Datos registrales. T 1222 , F 208, S 8, H L 24384, I/A 15 ( 3.10.12).

18/10/2012 Sec. I Nombramientos Lleida
Lleida-423810

Nombramientos — 18/10/2012

Nombramientos. Apo.Manc.: SALGADO MORA MARCELINO;MORALES TRESCENTS XAVIER. Datos registrales. T 1222 , F 208, S 8, H L 24384, I/A 16 ( 5.10.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 201 Jueves 18 de octubre de 20...

18/10/2012 Sec. I Nombramientos Lleida
Lleida-423811

Nombramientos — 18/10/2012

Nombramientos. Apoderado: CARRILLO BERMUDEZ ANTONIO. Datos registrales. T 1228 , F 155, S 8, H L 24384, I/A 17 ( 8.10.12).

07/02/2011 Sec. I Revocaciones Lleida
Lleida-52282

Revocaciones — 07/02/2011

Revocaciones. Apo.Sol.: CARRILLO BERMUDEZ ANTONIO;RODRIGUEZ MONTERDE RAFAEL. Datos registrales. T 1222 , F 206, S 8, H L 24384, I/A 11 (26.01.11).

07/02/2011 Sec. I Nombramientos Lleida
Lleida-52283

Nombramientos — 07/02/2011

Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ MONTERDE RAFAEL. Datos registrales. T 1222 , F 206, S 8, H L 24384, I/A 12 (26.01.11).

07/02/2011 Sec. I Nombramientos Lleida
Lleida-52284

Nombramientos — 07/02/2011

Nombramientos. Apoderado: CARRILLO BERMUDEZ ANTONIO. Datos registrales. T 1222 , F 207, S 8, H L 24384, I/A 13 (26.01.11).

07/02/2011 Sec. I Nombramientos Lleida
Lleida-52285

Nombramientos — 07/02/2011

Nombramientos. Apoderado: DUCH SOLE MONTSERRAT. Datos registrales. T 1222 , F 207, S 8, H L 24384, I/A 14 (26.01.11).

28/12/2010 Sec. I Cambio de objeto social Lleida
Lleida-481551

Cambio de objeto social — 28/12/2010

Cambio de objeto social. La comercialización en general en el mercado supranacional de harinas de carne destinadas al consumo humano y animal. Datos registrales. T 1222 , F 206, S 8, H L 24384, I/A 10 (16.12.10). BOLETÍ...

08/03/2010 Sec. I Cambio de domicilio social Lleida
Lleida-97712

Cambio de domicilio social — 08/03/2010

Cambio de domicilio social. CTRA N-II Km 529,5 (RIBERA D'ONDARA). Datos registrales. T 1222 , F 205, S 8, H L 24384, I/A 9 (25.02.10).