Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 22 tarjetas
17/12/2019 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-522330

Ampliación de capital — 17/12/2019

Ampliación de capital. Suscrito: 10.000.158,78 Euros. Desembolsado: 10.000.158,78 Euros. Resultante Suscrito: 13.112.282,91 Euros. Resultante Desembolsado: 13.112.282,91 Euros. Datos registrales. T 36999 , F 54, S 8, H...

16/12/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-518841

Ceses/dimisiones — 16/12/2019

Ceses/Dimisiones. Consejero: LATIL SOPHIE. Presidente: LATIL SOPHIE. Nombramientos. Consejero: LESNE JULIE ELISABETH MARTINE. Presidente: LESNE JULIE ELISABETH MARTINE. Datos registrales. T 36999 , F 54, S 8, H M 661098...

11/11/2019 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-464850

Nombramientos — 11/11/2019

Nombramientos. Apoderado: BENDZKO GEB SAHBI AZIZA. Datos registrales. T 36999 , F 54, S 8, H M 661098, I/A 14 ( 4.11.19).

04/11/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-454911

Ceses/dimisiones — 04/11/2019

Ceses/Dimisiones. Consejero: PLAZA LOZANO JOSE MARIA. Datos registrales. T 36999 , F 54, S 8, H M 661098, I/A 13 (25.10.19).

06/09/2019 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-383515

Nombramientos — 06/09/2019

Nombramientos. Apoderado: FRIEDRICH ANDREAS NICOLAS. Datos registrales. T 36999 , F 53, S 8, H M 661098, I/A 11 (30.08.19).

06/09/2019 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-383516

Nombramientos — 06/09/2019

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ COTORRUELO ERNESTO. Datos registrales. T 36999 , F 53, S 8, H M 661098, I/A 12 (30.08.19).

09/07/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-294564

Ceses/dimisiones — 09/07/2019

Ceses/Dimisiones. Consejero: MORELLI SERGE;JANTET BRUNO;REGIMBEAU FRANZ;RIGNAULT JEAN PAUL FRANCOIS. Con.Delegado: LATIL SOPHIE. Nombramientos. Consejero: PESTANA ROSA JOSE NUNO. Con.Delegado: TRUJILLO MARTIN MAITE. Dat...

16/04/2019 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-170561

Nombramientos — 16/04/2019

Nombramientos. Apo.Sol.: TRUJILLO MARTIN MAITE;PESTANA ROSA NUNO. Datos registrales. T 36999 , F 51, S 8, H M 661098, I/A 9 ( 9.04.19).

23/01/2019 Sec. I Ampliacion del objeto social Madrid
Madrid-29774

Ampliacion del objeto social — 23/01/2019

Ampliacion del objeto social. Adquisicion, parcelacion, explotacion y venta de terrenos, prfomocion, edificación y venta de bienes, locales y edificios. Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: HOGAR SOLUCIONES 2012...

03/01/2019 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-1856

Ampliación de capital — 03/01/2019

Ampliación de capital. Suscrito: 2.000.254,13 Euros. Desembolsado: 2.000.254,13 Euros. Resultante Suscrito: 3.112.124,13 Euros. Resultante Desembolsado: 3.112.124,13 Euros. Datos registrales. T 36999 , F 46, S 8, H M 66...

11/05/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-202475

Nombramientos — 11/05/2018

Nombramientos. Apoderado: MONTER PUERTO PABLO. Datos registrales. T 36999 , F 46, S 8, H M 661098, I/A 5 ( 3.05.18).

19/03/2018 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-125488

Reelecciones — 19/03/2018

Reelecciones. Consejero: REGIMBEAU FRANZ;RIGNAULT JEAN PAUL FRANCOIS;PLAZA LOZANO JOSE MARIA. Datos registrales. T 36999 , F 45, S 8, H M 661098, I/A 4 ( 9.03.18).

29/01/2018 Sec. I Ampliacion del objeto social Madrid
Madrid-44434

Ampliacion del objeto social — 29/01/2018

Ampliacion del objeto social. La prestación de toda clase de servicios, incluyendo aquéllos que se requieran para la asistencia a vehículos automóviles y a sus ocupantes en caso de avería..... La distribución de toda cl...

12/01/2018 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-17241

Cambio de domicilio social — 12/01/2018

Cambio de domicilio social. C/ AREQUIPA 1 (MADRID). Datos registrales. T 36999 , F 44, S 8, H M 661098, I/A 2 ( 5.01.18).

07/02/2017 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-60136

Revocaciones — 07/02/2017

Revocaciones. APODERADO: TRUJILLO MARTIN MARIA TERESA. Datos registrales. T 43650 , F 36, S 8, H B 16413, I/A 70 (31.01.17).

27/12/2016 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-523123

Nombramientos — 27/12/2016

Nombramientos. APODERAD.SOL: NUNO TIAGO DE MELLO SAMPAYO E ABRANTES. Datos registrales. T 43650 , F 36, S 8, H B 16413, I/A 69 (16.12.16).

20/12/2016 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-512571

Nombramientos — 20/12/2016

Nombramientos. CONSEJERO: BRUNO JANTET;SERGE MORELLI. PRESIDENTE: BRUNO JANTET. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 29 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIA...

26/05/2016 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-223469

Revocaciones — 26/05/2016

Revocaciones. APODERADO: LAMARCA CAPA ENRIQUE;RODRIGUEZ GUARDIA JOSE;CASTRO DIAZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 43650 , F 34, S 8, H B 16413, I/A 63 (18.05.16).

30/10/2015 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-437723

Revocaciones — 30/10/2015

Revocaciones. CONSEJERO: LAMARCA CAPA ENRIQUE. CONS. DELEG.: LAMARCA CAPA ENRIQUE. Nombramientos. CONS. DELEG.: SOPHIE LATIL. AUDIT.CUENT.: MAZARS AUDITORES SLP. CONSEJERO: TRUJILLO MARTIN MAITE. Datos registrales. T 43...

09/01/2015 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-5814

Nombramientos — 09/01/2015

Nombramientos. APODERAD.SOL: SOPHIE LATIL. Datos registrales. T 43650 , F 31, S 8, H B 16413, I/A 59 (30.12.14).

15/02/2013 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-76508

Nombramientos — 15/02/2013

Nombramientos. APODERADO: CAÑAS GARCIA JOSE FELIX. Datos registrales. T 42384 , F 50, S 8, H B 16413, I/A 55 ( 7.02.13).

07/02/2013 Sec. I Modificaciones estatutarias Barcelona
Barcelona-61539

Modificaciones estatutarias — 07/02/2013

Modificaciones estatutarias. MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 42384 , F 47, S 8, H B 16413, I/A 53 (29.01.13).