Actos destacados
Cancelaciones de oficio de nombramientos — 10/10/2016
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Vicesecret.: CASTRO FERNANDEZ LUCIA. Reelecciones. Vicesecret.: ALARCON BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 194 Lunes 10 de octubre de 2016 Pág. 44227 cve: BORME-A-2016-...
Nombramientos — 10/10/2016
Nombramientos. Apoderado: GARCIA MORALES ALFONSO-LUIS. Datos registrales. T 2584 , F 88, S 8, H C 26761, I/A 24 (29.09.16).
Nombramientos — 10/10/2016
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ PEREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 2584 , F 89, S 8, H C 26761, I/A 25 (29.09.16).
Reelecciones — 31/08/2015
Reelecciones. Secretario: GARCIA DE LOS REYES-GARCIA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2584 , F 88, S 8, H C 26761, I/A 22 (25.08.15).
Nombramientos — 17/09/2013
Nombramientos. Apoderado: SANTOS LOPEZ IGNACIO. Datos registrales. T 2463 , F 213, S 8, H C 26761, I/A 21 (10.09.13).
Nombramientos — 17/10/2012
Nombramientos. Apoderado: SANGIL DEL RIO CARLOS. Datos registrales. T 2463 , F 213, S 8, H C 26761, I/A 19 ( 8.10.12).
Reelecciones — 31/08/2012
Reelecciones. Consejero: COLLAZO MATO JULIO. Datos registrales. T 2463 , F 212, S 8, H C 26761, I/A 17 (22.08.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 167 Viernes 31 de agosto de 2012 Pág. 39455 cve: BORME-A-201...
Reelecciones — 31/08/2012
Reelecciones. Consejero: COLLAZO MATO JOSE. Presidente: COLLAZO MATO JOSE. Consejero: COLLAZO MATO MANUEL. Datos registrales. T 2463 , F 213, S 8, H C 26761, I/A 18 (22.08.12).
Revocaciones — 14/06/2012
Revocaciones. Apoderado: DEL SOL RODRIGUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 2463 , F 212, S 8, H C 26761, I/A 16 ( 5.06.12).
Revocaciones — 01/06/2012
Revocaciones. Apo.Sol.: IGLESIAS DIAZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 2463 , F 212, S 8, H C 26761, I/A 15 (23.05.12).
Nombramientos — 20/03/2012
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA DE LOS REYES FRANCISCO JAVIER;GARCIA LOBO MANUEL ALEJANDRO. Datos registrales. T 2463 , F 212, S 8, H C 26761, I/A 14 ( 8.03.12).
Nombramientos — 18/07/2011
Nombramientos. Apoderado: MARTIN MENDEZ OLEGARIO CECILIO. Datos registrales. T 2463 , F 211, S 8, H C 26761, I/A 13 ( 8.07.11).
Nombramientos — 16/06/2011
Nombramientos. Apoderado: DEL SOL RODRIGUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 2463 , F 210, S 8, H C 26761, I/A 12 ( 6.06.11).
Revocaciones — 10/06/2011
Revocaciones. Apoderado: GALAN OTERO JUAN CAMILO. Nombramientos. Apo.Sol.: IGLESIAS DIAZ JOSE ANTONIO;GALAN OTERO JUAN CAMILO. Datos registrales. T 2463 , F 209, S 8, H C 26761, I/A 10 (31.05.11).
Nombramientos — 10/06/2011
Nombramientos. Apoderado: GARCIA DE LOS REYES FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2463 , F 210, S 8, H C 26761, I/A 11 (31.05.11).
Cancelaciones de oficio de nombramientos — 10/03/2011
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Secretario: GARCIA DE LOS REYES FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2463 , F 208, S 8, H C 26761, I/A NM4 ( 2.03.11).
Otros conceptos: se rectifica el domicilio social y el artículo 6º de los estatutos como consecuencia de la asignación, por parte del ayuntamiento, de número al local en que se encuentra la sede social, quedando el mismo establecido en a coruña, avenida enrique salgado torres, número 11 — 02/07/2010
Otros conceptos: Se rectifica el domicilio social y el Artículo 6º de los Estatutos como consecuencia de la asignación, por parte del Ayuntamiento, de número al local en que se encuentra la sede social, quedando el mism...
Nombramientos — 28/12/2009
Nombramientos. Vicesecret.: CASTRO FERNANDEZ LUCIA;ALARCON UROSA MARIA DEL ROCIO. Datos registrales. T 2463 , F 209, S 8, H C 26761, I/A 7 (16.12.09).
Ceses/dimisiones — 07/07/2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA MORALES CARLOS ANDRES. Nombramientos. Consejero: COLLAZO MATO JULIO. Datos registrales. T 2463 , F 209, S 8, H C 26761, I/A 6 (29.06.09).