Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 6 tarjetas
28/11/2018 Sec. I Disolución Madrid
Madrid-476430

Disolución — 28/11/2018

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 31561 , F 171, S 8, H M 548566, I/A 21 (20.11.18).

19/10/2018 Sec. I Sociedad unipersonal Madrid
Madrid-418940

Sociedad unipersonal — 19/10/2018

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: BANKIA SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: CORPORACION EMPRESARIAL MARE NOSTRUM SL;GESNOSTRUM SOCIEDAD GESTORA SL;GESMARE SOCIEDAD GESTORA SL;VECTOR CAPITAL SL EN...

29/07/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-314423

Revocaciones — 29/07/2016

Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ-BERMEJO BERMEJO DAVID. Datos registrales. T 31561 , F 169, S 8, H M 548566, I/A 19 (20.07.16).

22/07/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-303310

Nombramientos — 22/07/2015

Nombramientos. Representan: ESPIGARES CERDAN JOAQUIN;MARTINEZ BERMEJO BERMEJO DAVID. Consejero: VECTOR CAPITAL SL;SERNOSTRUM SL. Datos registrales. T 31561 , F 164, S 8, H M 548566, I/A 15 (14.07.15).

22/07/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-303311

Revocaciones — 22/07/2015

Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALMAGRO GONZALEZ FRANCISCO;ALONSO MUNAR NEUS;MORENO MOLINO JOSE MANUEL. Apo.Sol.: GUTIERREZ CONDE ROSA;MARTINEZ MERCADO MANUEL;AROCA GUARDIOLA JOSEFA;ALZAMORA ROVIRA GABRIEL;LLORET MANCHON AN...

13/11/2014 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-459784

Modificaciones estatutarias — 13/11/2014

Modificaciones estatutarias. SE DA NUEVA REDACCION AL ARTICULO 11 DE LOS ESTATUTOS. . Datos registrales. T 31561 , F 162, S 8, H M 548566, I/A 11 ( 4.11.14).