Actos destacados
INICIATIVES MUNICIPALS DE VILA SOCIEDAD ANONIMA(R.M. EIVISSA)
Ceses/Dimisiones. Consejero: CORRAL JOVEN GLORIA;FAJARNES COSTA MARIA;LOPEZ BONED ELENA;MOLINA JIMENEZ ILDEFONSO;RIBAS FERRER JUAN. Vicepresid.: RIBAS FERRER JUAN. Consejero: RUIZ GONZALEZ RAFAEL. Presidente: RUIZ GONZA...
INICIATIVES MUNICIPALS DE VILA SOCIEDAD ANONIMA(R.M. EIVISSA)
Reelecciones. Auditor: SPASA AUDITORIA S.L.P. Datos registrales. T 295, L 294, F 142, S 8, H IB 7098, I/A 30 (12.01.18).
Revocaciones — 25/10/2016
Revocaciones. Apoderado: RIBAS FERRER JUAN. Datos registrales. T 295, L 294, F 141, S 8, H IB 7098, I/A 28 (14.10.16).
Nombramientos — 25/10/2016
Nombramientos. Apoderado: MOLINA JIMENEZ ILDEFONSO. Datos registrales. T 295, L 294, F 141, S 8, H IB 7098, I/A 29 (14.10.16).
Ampliación de capital — 22/02/2016
Ampliación de capital. Suscrito: 4.095.300,00 Euros. Desembolsado: 4.095.300,00 Euros. Resultante Suscrito: 11.172.200,00 Euros. Resultante Desembolsado: 11.172.200,00 Euros. Datos registrales. T 295, L 294, F 140, S 8,...
Ceses/dimisiones — 16/10/2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANSANO COSTA CATALINA;COSTA TUR MARC;VILLALONGA JUAN ANTONIO;MARI RENNESSON VIRGINIA;FLORES JIMENEZ JUAN;SANCHEZ GUTIERREZ MARIA DEL MAR;MOLINA JIMENEZ ILDEFONSO. Presidente: MARI RENNESSON...
Nombramientos — 16/10/2015
Nombramientos. Apoderado: RIBAS FERRER JUAN. Datos registrales. T 295, L 294, F 139, S 8, H IB 7098, I/A 24 ( 8.10.15).
Revocaciones — 16/10/2015
Revocaciones. Apoderado: PRATS RAMOS RAIMUNDO. Datos registrales. T 295, L 294, F 139, S 8, H IB 7098, I/A 25 ( 8.10.15).
Cesión global de activo y pasivo — 25/09/2015
Cesión global de activo y pasivo. Beneficiarias de la cesión: INICIATIVES MUNICIPALS DE VILA, SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 272, L 271, F 128, S 8, H IB 7098, I/A 22 (18.09.15).
Ceses/dimisiones — 10/09/2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARI FERRER ALEJANDRO;FERRER BARBANY VICENTE;PRATS RAMOS RAIMUNDO. Presidente: MARI TORRES MARIA DEL PILAR. Consejero: MARI TORRES MARIA DEL PILAR;RODRIGO MATEO IGNACIO. Vicepresid.: PRATS R...
Ceses/dimisiones — 10/09/2015
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: VELASCO NIETO ZULEMA. Nombramientos. Presidente: MARI RENNESSON VIRGINIA. Vicepresid.: SANCHEZ GUTIERREZ MARIA DEL MAR. Secretario: FAJARNES COSTA MARIA. Datos registrales. T 272, L 271,...
Fe de erratas: se publicó que el nombramiento de doña zulema velasco nieto era como liquidadora, cuando era como secretaria no consejera — 16/02/2015
Fe de erratas: Se publicó que el nombramiento de doña Zulema Velasco Nieto era como Liquidadora, cuando era como Secretaria no Consejera. Datos registrales. T 272, L 271, F 126, S 8, H IB 7098, I/A 17 (27.11.14).
Ceses/dimisiones — 04/12/2014
Ceses/Dimisiones. Gerente: PEREZ ECHAGUE EMILIO. Secretario: ROCA MATA JOAQUIN. Gerente: MOUAFFAK SANZ NASSER. Revocaciones. Apo.Sol.: MOUAFFAK SANZ NASSER. Apoderado: SANCHEZ-JAUREGUI MARTINEZ MARIENNA;MOUAFFAK SANZ NA...
Ampliación de capital — 04/12/2014
Ampliación de capital. Suscrito: 1.510.000,00 Euros. Desembolsado: 1.510.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.746.900,00 Euros. Resultante Desembolsado: 6.746.900,00 Euros. Datos registrales. T 272, L 271, F 126, S 8, H...
Ampliación de capital — 04/12/2014
Ampliación de capital. Suscrito: 1.840.000,00 Euros. Desembolsado: 1.840.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 7.076.900,00 Euros. Resultante Desembolsado: 7.076.900,00 Euros. Datos registrales. T 272, L 271, F 127, S 8, H...
Nombramientos — 22/11/2013
Nombramientos. Apoderado: PRATS RAMOS RAIMUNDO. Datos registrales. T 158, L 157, F 66, S 8, H IB 7098, I/A 14 (15.11.13).
Nombramientos — 22/11/2013
Nombramientos. Presidente: MARI TORRES MARIA DEL PILAR. Vicepresid.: PRATS RAMOS RAIMUNDO. Datos registrales. T 272, L 271, F 126, S 8, H IB 7098, I/A 16 (15.11.13).
Ceses/dimisiones — 22/11/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ-JAUREGUI MARTINEZ MARIENNA. Presidente: SANCHEZ-JAUREGUI MARTINEZ MARIENNA. Consejero: SANCHEZ GUTIERREZ MARIA DEL MAR. Nombramientos. Consejero: MARI TORRES MARIA DEL PILAR;RODRIGO...
Nombramientos — 08/05/2013
Nombramientos. Consejero: PRATS RAMOS RAIMUNDO;SANCHEZ GUTIERREZ MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 158, L 157, F 66, S 8, H IB 7098, I/A 13 (26.04.13).
Ceses/dimisiones — 30/11/2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: MAYANS CRUZ JUAN. Vicepresid.: DAURA ESCANDELL JUAN. Datos registrales. T 158, L 157, F 66, S 8, H IB 7098, I/A 12 (20.11.12).
Nombramientos — 25/09/2012
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ-JAUREGUI MARTINEZ MARIENNA;MOUAFFAK SANZ NASSER. Datos registrales. T 158, L 157, F 66, S 8, H IB 7098, I/A 11 (17.09.12).
Ceses/dimisiones — 19/07/2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: COSTA TORRES LURDES;PIZARRO SIMON SANTIAGO;TORRES RAMON VICENTE;RUBIO CORDOBA JUAN MANUEL;COSTA TUR MARC;MARI FERRER MARIA VIRTUDES;DIAZ DE ENTRESOTOS CORTES JAIME LEON;MARI FERRER ALEJANDRO...
Nombramientos — 21/07/2009
Nombramientos. Auditor: ANTONIO LUIS MARI AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 158, L 157, F 64, S 8, H IB 7098, I/A 7 ( 8.07.09).