Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 7 tarjetas
10/02/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-60317

Revocaciones — 10/02/2016

Revocaciones. Apoderado: MORENO PERAL ISAAC. Datos registrales. T 27933 , F 59, S 8, H M 143143, I/A 54 ( 3.02.16).

22/01/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-28937

Nombramientos — 22/01/2014

Nombramientos. Apo.Manc.: ARMENTEROS MENENDEZ JOSE IGNACIO;MARTIN DE BLAS JOSE MARIA;SERETI LOPEZ SAHARA. Datos registrales. T 27933 , F 59, S 8, H M 143143, I/A 52 (14.01.14).

20/12/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-544819

Ceses/dimisiones — 20/12/2013

Ceses/Dimisiones. Representan: FERNANDEZ DEL VISO MORAN LUCIA. Nombramientos. Representan: MARTINEZ PEREZ DE TUDELA BENITO. Datos registrales. T 27933 , F 58, S 8, H M 143143, I/A 51 (12.12.13).

02/06/2011 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-236047

Ampliación de capital — 02/06/2011

Ampliación de capital. Capital: 2.256.999,20 Euros. Resultante Suscrito: 5.394.843,20 Euros. Datos registrales. T 27933 , F 55, S 8, H M 143143, I/A 45 (23.05.11).

16/09/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-353284

Ceses/dimisiones — 16/09/2010

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: CORONEL DE PALMA Y MARTINEZ AGULLO ALFONSO. Presidente: CORONEL DE PALMA Y MARTINEZ AGULLO ALFONSO. Nombramientos. Presidente: BURILLO AZCARRAGA EMILIO. Vicepresid.: CORONEL DE PALMA Y MA...

29/03/2010 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-127961

Reelecciones — 29/03/2010

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 17359 , F 167, S 8, H M 143143, I/A 34 (16.03.10).

31/12/2009 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-545359

Ceses/dimisiones — 31/12/2009

Ceses/Dimisiones. Consejero: GIMENEZ BARRIOCANAL FERNANDO. Datos registrales. T 17359 , F 167, S 8, H M 143143, I/A 33 (18.12.09).