Actos destacados
Reelecciones — 21/08/2019
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 1524 , F 189, S 8, H VA 18575, I/A 22 (13.08.19). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Ceses/dimisiones — 01/08/2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MURO LUCAS ALBERTO BALTASAR. Consejero: RODRIGUEZ JUAN CARLOS PABLO;GESTION 99 SL. Presidente: RODRIGUEZ JUAN CARLOS PABLO. Consejero: BERNARDEZ PEREZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Adm. Sol...
Ceses/dimisiones — 01/06/2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: ADE CAPITAL SODICAL S.C.R. SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 1524 , F 188, S 8, H VA 18575, I/A 19 (25.05.18).
Ceses/dimisiones — 01/06/2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MARTIN SORIA CARLOS. Nombramientos. SecreNoConsj: MURO LUCAS ALBERTO BALTASAR. Datos registrales. T 1524 , F 188, S 8, H VA 18575, I/A 20 (25.05.18).
Nombramientos — 14/12/2017
Nombramientos. Consejero: BERNARDEZ PEREZ JOSE MANUEL. Otros conceptos: -Se modifica el artículo 8.1. -Se modifican los artículos 11 y 12. -Se modifica el artículo 21. --Se procede, igualmente, a REFUNDIR LOS ESTATUTOS...
Ceses/dimisiones — 08/05/2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ JUAN CARLOS PABLO;BERNARDEZ PEREZ JOSE MANUEL;GESTION 99 SL. Presidente: BERNARDEZ PEREZ JOSE MANUEL. Vicepresid.: RODRIGUEZ JUAN CARLOS PABLO. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ...
Ceses/dimisiones — 01/03/2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: ADE CAPITAL SODICAL S.C.R. SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 1406 , F 219, S 8, H VA 18575, I/A 16 (22.02.17).
Nombramientos — 20/01/2017
Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 1406 , F 219, S 8, H VA 18575, I/A 15 (13.01.17).
Ceses/dimisiones — 22/06/2016
Ceses/Dimisiones. Presidente: RODRIGUEZ JUAN CARLOS PABLO. Vicepresid.: BERNARDEZ PEREZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Presidente: BERNARDEZ PEREZ JOSE MANUEL. Vicepresid.: RODRIGUEZ JUAN CARLOS PABLO. Datos registrales. T...
Nombramientos — 08/06/2016
Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES VLL SL. Datos registrales. T 1406 , F 219, S 8, H VA 18575, I/A 13 ( 1.06.16).
Cambio de domicilio social — 17/10/2012
Cambio de domicilio social. C/ LUIS PROUST 10 - PARQUE TECNOLOGICO DE BOECILLO (BOECILLO). Datos registrales. T 1406 , F 219, S 8, H VA 18575, I/A 12 ( 5.10.12).
Nombramientos — 31/01/2012
Nombramientos. Consejero: ADE CAPITAL SODICAL SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE. Datos registrales. T 1262 , F 195, S 8, H VA 18575, I/A 11 (20.01.12).
Nombramientos — 27/12/2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BERNARDEZ PEREZ JOSE MANUEL. Apo.Sol.: RODRIGUEZ JUAN CARLOS PABLO. Datos registrales. T 1262 , F 195, S 8, H VA 18575, I/A 10 (16.12.11).
Ceses/dimisiones — 23/12/2011
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: RODRIGUEZ JUAN CARLOS PABLO;BERNARDEZ PEREZ JOSE MANUEL. Nombramientos. SecreNoConsj: MARTIN SORIA CARLOS. Consejero: RODRIGUEZ JUAN CARLOS PABLO. Presidente: RODRIGUEZ JUAN CARLOS PABLO....
Ceses/dimisiones — 10/08/2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ JUAN CARLOS PABLO;BERNARDEZ PEREZ JOSE MANUEL;LOPEZ GONZALEZ CARLOS;LLORENTE MUÑOZ FRANCISCO JAVIER. Presidente: RODRIGUEZ JUAN CARLOS PABLO. Secretario: BERNARDEZ PEREZ JOSE MANUE...
Reducción de capital — 05/10/2009
Reducción de capital. Importe reducción: 3.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 97.000,00 Euros. Ampliación de capital. Suscrito: 3.000,00 Euros. Desembolsado: 3.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 100.000,00 Euros. Result...