Actos destacados
Ceses/dimisiones — 13/01/2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: CAMPOS SANTOS JOSE;CAMPOS SANTOS ANTONIO. Revocaciones. Apo.Manc.: GRANADOS CAMPOS ALFONSO;MORENO MOLINILLO JOSE. Apoderado: TALAYA COLLADO JOSE;QUISLANT PEREZ DIEGO JOSE. Disolución. Fusi...
Ampliación de capital — 23/06/2014
Ampliación de capital. Capital: 1.302.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.308.200,00 Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 9º. ADMINISTRACION. 1. Estructura del órgano de administración.- La gestión y representa...
Ampliacion del objeto social — 20/01/2014
Ampliacion del objeto social. El desarrollo de soluciones industriales basadas en el control remoto de equipos, la realizacion de estudios, planificacion,ejecucion y mantenimiento de dichas soluciones, asi como su comer...
Ampliación de capital — 08/01/2014
Ampliación de capital. Capital: 3.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.200,00 Euros. Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: APLICACIONES TELECONTROLADAS URBANTEC SOCIEDAD LIM. Datos registrales. T 930, L 694, F 35...
Ceses/dimisiones — 31/10/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPOS SANTOS JOSE;CAMPOS SANTOS ANTONIO;GRANADOS CAMPOS ALFONSO;MORENO MOLINILLO JOSE. Presidente: CAMPOS SANTOS JOSE. Vicepresid.: CAMPOS SANTOS ANTONIO. Secretario: GRANADOS CAMPOS ALFONS...
Nombramientos — 09/04/2013
Nombramientos. Apoderado: QUISLANT PEREZ DIEGO JOSE. Datos registrales. T 909, L 673, F 97, S 8, H AB 17693, I/A 12 ( 2.04.13).
Revocaciones — 07/12/2012
Revocaciones. Apoderado: FLORES CORCOLES ANTONIO;PACHECO ALCARRIA JORGE;SAEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 909, L 673, F 97, S 8, H AB 17693, I/A 11 (28.11.12).
Revocaciones — 05/10/2011
Revocaciones. Apo.Manc.: AGUILAR GARRIDO PILAR. Datos registrales. T 909, L 673, F 97, S 8, H AB 17693, I/A 10 (26.09.11).
Nombramientos — 12/08/2011
Nombramientos. Apoderado: TALAYA COLLADO JOSE. Datos registrales. T 907, L 671, F 92, S 8, H AB 17693, I/A 9 ( 3.08.11).
Ceses/dimisiones — 10/06/2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: FLORES CORCOLES ANTONIO;CAMPOS SANTOS JOSE;CAMPOS SANTOS ANTONIO;LUCAS PEREZ MIGUEL;PACHECO ALCARRIA JORGE. Presidente: CAMPOS SANTOS JOSE. Vicepresid.: CAMPOS SANTOS ANTONIO. Secretario: FL...
Nombramientos — 10/06/2011
Nombramientos. Apo.Manc.: GRANADOS CAMPOS ALFONSO;AGUILAR GARRIDO PILAR;MORENO MOLINILLO JOSE. Datos registrales. T 895, L 659, F 13, S 8, H AB 17693, I/A 8 ( 1.06.11).
Nombramientos — 23/04/2010
Nombramientos. Apoderado: SAEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 891, L 655, F 134, S 8, H AB 17693, I/A 5 (14.04.10).
Nombramientos — 23/04/2010
Nombramientos. Apoderado: PACHECO ALCARRIA JORGE. Datos registrales. T 895, L 659, F 13, S 8, H AB 17693, I/A 6 (14.04.10).
Nombramientos — 08/02/2010
Nombramientos. Apoderado: FLORES CORCOLES ANTONIO. Datos registrales. T 891, L 655, F 134, S 8, H AB 17693, I/A 4 (28.01.10).
Ceses/dimisiones — 15/01/2010
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LUCAS PEREZ MIGUEL;PACHECO ALCARRIA JORGE. Nombramientos. Consejero: FLORES CORCOLES ANTONIO;CAMPOS SANTOS JOSE;CAMPOS SANTOS ANTONIO;LUCAS PEREZ MIGUEL;PACHECO ALCARRIA JORGE. Presidente:...
Ampliacion del objeto social — 07/01/2009
Ampliacion del objeto social. la actividad de suministrar equipos muebles y vehículos con o y sin motor. Datos registrales. T 844, L 608, F 3, S 8, H AB 17693, I/A 2 (23.12.08).