Actos destacados
Cambio de denominación social — 12/12/2017
Cambio de denominación social. ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES, S.L. Cambio de objeto social. Manipulado, fabricación y montaje de productos para empresas. Fabricación, montaje y venta de piezas de inyección de plástico....
Revocaciones — 06/10/2017
Revocaciones. Apoderado: MARTIN JIMENEZ JUAN-MANUEL;FERNANDEZ FIDALGO CESAR ALEJANDRO;BONILLA LEO FRANCISCA;DEL POZO GARZON NURIA;FERNANDEZ FIDALGO CESAR ALEJANDRO;SOLANO IRIGOYEN IGNACIO. Apo.Man.Soli: FUERTES GARCIA R...
Nombramientos — 06/10/2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: AGUILAR BARRON FERNANDO. Datos registrales. T 600 , F 205, S 8, H GU 9813, I/A 10 (28.09.17).
Nombramientos — 06/10/2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SOLANO IRIGOYEN IGNACIO. Datos registrales. T 600 , F 207, S 8, H GU 9813, I/A 11 (28.09.17).
Nombramientos — 06/10/2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANZ CAMPOS DAVID. Datos registrales. T 600 , F 208, S 8, H GU 9813, I/A 12 (28.09.17).
Nombramientos — 27/03/2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PALMERO MANGADO VIRGINIA. Datos registrales. T 600 , F 204, S 8, H GU 9813, I/A 7 (13.03.17).
Nombramientos — 27/03/2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CAMARENA GONZALEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 600 , F 204, S 8, H GU 9813, I/A 8 (13.03.17).
Nombramientos — 17/02/2017
Nombramientos. Apoderado: DEL MOREL DE LAMO LORENA. Datos registrales. T 600 , F 202, S 8, H GU 9813, I/A 4 ( 9.02.17).
Reelecciones — 17/02/2017
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 600 , F 203, S 8, H GU 9813, I/A 5 ( 9.02.17).
Reelecciones — 17/02/2017
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 600 , F 203, S 8, H GU 9813, I/A 6 ( 9.02.17).
Revocaciones — 13/09/2016
Revocaciones. Apoderado: FLOR GONZALEZ MARIA VICTORIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARELLANO GONZALEZ JORGE;SUAREZ SAIZ RAQUEL;INGELMO DE LA MATA JOAQUIN;PEDROTE GARCIA FERNANDO;NAVARRO HIGUERA MERCEDES;BIDAURRAZAGA MAR...
Cambio de domicilio social — 29/04/2016
Cambio de domicilio social. AVDA CASTILLA LA MANCHA 11 (CABANILLAS DEL CAMPO). Datos registrales. T 600 , F 201, S 8, H GU 9813, I/A 2 (18.04.16).
Nombramientos — 05/04/2016
Nombramientos. Apoderado: FLOR GONZALEZ MARIA VICTORIA. Datos registrales. T 33550 , F 8, S 8, H M 133901, I/A 63 (29.03.16).
Nombramientos — 05/04/2016
Nombramientos. Apoderado: ARELLANO GONZALEZ JORGE. Datos registrales. T 33550 , F 8, S 8, H M 133901, I/A 64 (29.03.16).
Nombramientos — 14/01/2016
Nombramientos. Apoderado: BUESA GARCIA PEDRO. Datos registrales. T 33550 , F 7, S 8, H M 133901, I/A 61 ( 5.01.16).
Revocaciones — 09/09/2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PISTON RODRIGUEZ CARMEN. Datos registrales. T 33550 , F 6, S 8, H M 133901, I/A 58 (31.08.15).
Nombramientos — 09/09/2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SUAREZ SAIZ RAQUEL. Datos registrales. T 33550 , F 6, S 8, H M 133901, I/A 59 (31.08.15).
Nombramientos — 09/09/2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: AGUILAR BARRON FERNANDO. Datos registrales. T 33550 , F 6, S 8, H M 133901, I/A 60 (31.08.15).