Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 5 tarjetas
02/12/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-489336

Ceses/dimisiones — 02/12/2016

Ceses/Dimisiones. Secretario: VON CARSTENN-LICHTERFELDE MENENDEZ FERNANDO. Consejero: GASPARI ROBERTO;SEGMULLER MICHAEL ANDREAS. Presidente: SEGMULLER MICHAEL ANDREAS. Cons.Del.Sol: SEGMULLER MICHAEL ANDREAS. Consejero:...

11/08/2016 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-334670

Reelecciones — 11/08/2016

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30532 , F 221, S 8, H M 313551, I/A 31 ( 4.08.16).

15/10/2015 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-414233

Reelecciones — 15/10/2015

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30532 , F 221, S 8, H M 313551, I/A 29 ( 6.10.15).

11/05/2015 Sec. I Sociedad unipersonal Madrid
Madrid-190907

Sociedad unipersonal — 11/05/2015

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: KABA INTERNATIONAL HOLDING AG. Datos registrales. T 30532 , F 216, S 8, H M 313551, I/A 26 (30.04.15).

28/12/2009 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-537838

Reelecciones — 28/12/2009

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 18124 , F 52, S 8, H M 313551, I/A 12 (14.12.09).