Actos destacados
Revocaciones — 09/05/2019
Revocaciones. Apoderado: GIL DE BERNABE RIVERO IGNACIO. Nombramientos. Apo.Sol.: CASTRO ALVAREZ DANIEL;NOVA PALOMARES JUAN PEDRO. Cambio de denominación social. CAETANO FORMULA CADIZ SL. Datos registrales. T 2207 , F 13...
Reelecciones — 27/12/2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2207 , F 130, S 8, H CA 38361, I/A 41 (17.12.18).
Revocaciones — 11/09/2018
Revocaciones. Apo.Manc.: GIL DE BERNABE RIVERO IGNACIO. Apo.Sol.: GIL DE BERNABE RIVERO IGNACIO;GIL DE BERNABE RIVERO IGNACIO. Datos registrales. T 2207 , F 130, S 8, H CA 38361, I/A 40 (31.08.18).
Revocaciones — 27/02/2018
Revocaciones. Apo.Sol.: DEL CASTILLO BENITEZ CARLOS ALFONSO. Apo.Man.Soli: ALVAREZ PEREZ JOSE ANTONIO. Apo.Sol.: FERNANDEZ HARO JUAN JOSE;ROSADO ARROYAL SANTIAGO;TERCERO COCA ERNESTINA;SANJUAN CHAMIZO MARTA;FERNANDEZ HA...
Nombramientos — 27/12/2017
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2207 , F 129, S 8, H CA 38361, I/A 38 (18.12.17).
Ceses/dimisiones — 17/05/2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: FIDALGO CERVIÑO ALEJANDRO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: FIDALGO CERVIÑO ALEJANDRO. Nombramientos. Adm. Mancom.: OLIVEIRA DA SILVA TORRES HUGO MANUEL. Apo.Man.Soli: OLIVEIRA DA SILVA TORRES...
Nombramientos — 17/05/2017
Nombramientos. Adm. Mancom.: NOGUEIRA PEREIRA PAULO MANUEL. Modificaciones estatutarias. "ARTICULO 20.- Organo de administración. La administración y representación de la Sociedad y el uso de la firma social, correspond...
Nombramientos — 02/02/2017
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2207 , F 126, S 8, H CA 38361, I/A 35 (26.01.17).
Nombramientos — 29/08/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: NOVA PALOMARES JUAN PEDRO;DEL CASTILLO BENITEZ CARLOS ALFONSO. Datos registrales. T 2207 , F 126, S 8, H CA 38361, I/A 34 (22.08.16). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 164 Lunes 29 de...
Reelecciones — 26/01/2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2117 , F 105, S 8, H CA 38361, I/A 33 (15.01.16).
Revocaciones — 08/01/2016
Revocaciones. Apo.Manc.: FERNANDEZ HARO JUAN JOSE. Datos registrales. T 2117 , F 105, S 8, H CA 38361, I/A 32 (30.12.15).
Modificaciones estatutarias — 07/01/2016
Modificaciones estatutarias. NUEVOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 2117 , F 99, S 8, H CA 38361, I/A 31 (24.12.15).
Revocaciones — 27/10/2015
Revocaciones. Apo.Manc.: ROSADO ARROYAL SANTIAGO. Apo.Man.Soli: PLA CUCURULL JOAN. Apo.Manc.: PLA CUCURULL JOAN. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALVAREZ PEREZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 2117 , F 99, S 8, H CA 38361...
Nombramientos — 10/02/2015
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2117 , F 98, S 8, H CA 38361, I/A 29 (30.01.15).
Nombramientos — 07/01/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ PEREZ JOSE ANTONIO;OLMOS MIRONES ELENA;FERNANDEZ HARO JUAN JOSE;GIL DE BERNABE RIVERO IGNACIO;LOPEZ MARTIN JOSE LUIS;MARIN LOPEZ PEDRO;MARTINEZ CARMONA FRANCISCO DE PAULA;MATUTE SAINZ FR...
Revocaciones — 13/10/2014
Revocaciones. Apo.Manc.: LOPEZ MARTIN JOSE LUIS. Apo.Man.Soli: BRIALES AVILA FRANCISCO JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALVAREZ PEREZ JOSE ANTONIO. Apo.Sol.: MARTINEZ CARMONA FRANCISCO DE PAULA;RUIZ DEL PORTAL GUTIERR...
Revocaciones — 20/08/2014
Revocaciones. Apo.Manc.: SANJUAN CHAMIZO MARTA;TERCERO COCA ERNESTINA. Datos registrales. T 2117 , F 95, S 8, H CA 38361, I/A 26 (11.08.14).
Ceses/dimisiones — 13/05/2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: FERNANDEZ LLORENS JOSE LUIS. Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ LLORENS JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Mancom.: FIDALGO CERVIÑO ALEJANDRO. Apo.Man.Soli: PLA CUCURULL JOAN;PLA CUCURULL...
Nombramientos — 29/01/2014
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2038 , F 40, S 8, H CA 38361, I/A 24 (21.01.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 19 Miércoles 29 de enero de 2014 Pág. 4305 c...
Ceses/dimisiones — 28/05/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: BRIALES AVILA FRANCISCO JOSE;SINDE MONTEIRO DE ARAUJO PAULO JORGE;LORZA BLASCO RAFAEL. Presidente: LORZA BLASCO RAFAEL. Consejero: NOGUEIRA PEREIRA PAULO MANUEL. Secretario: OLMOS MIRONES EL...
Nombramientos — 31/10/2012
Nombramientos. Apoderado: GIL DE BERNABE RIVERO IGNACIO. Datos registrales. T 2038 , F 36, S 8, H CA 38361, I/A 20 (22.10.12).
Ceses/dimisiones — 31/10/2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ OVIEDO FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: NOGUEIRA PEREIRA PAULO MANUEL. Datos registrales. T 2038 , F 36, S 8, H CA 38361, I/A 21 (22.10.12). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIA...
Revocaciones — 19/07/2012
Revocaciones. Apo.Manc.: MERINO OSBORNE MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 2038 , F 36, S 8, H CA 38361, I/A 19 ( 9.07.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 137 Jueves 19 de julio de 2012 Pág. 33206 cve: BORM...
Revocaciones — 25/05/2012
Revocaciones. Apo.Manc.: VILLAGRAN YAÑEZ DIEGO. Datos registrales. T 2038 , F 36, S 8, H CA 38361, I/A 18 (16.05.12).