Actos destacados
Ceses/dimisiones — 12/12/2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PARDO MARTIN JOSE EMILIANO;DE LA MAYA VERDE JUAN LUIS. Revocaciones. Apoderado: OQUINA ALDAMA JOSE VICENTE. Apo.Sol.: FERNANDEZ GARCIA JULIO;CALLEJAS GONZALEZ MIGUEL;MARCOS SUAREZ MARGARIT...
Revocaciones — 16/08/2016
Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 964, L 728, F 128, S 8, H AB 1605, I/A 84 ( 9.08.16).
Declaración de unipersonalidad — 01/02/2016
Declaración de unipersonalidad. Socio único: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA. Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: TELLEZ MENCHEN JOSE AURELIO. SecreNoConsj: GONZALEZ CORREDOR YOLANDA. Consejero: ESCARDA GELAB...
Revocaciones — 01/09/2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PARDO MARTIN JOSE EMILIANO;GRANDA CAMPO JUAN RAMON. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PARDO MARTIN JOSE EMILIANO. Apo.Manc.: DE LA MAYA VERDE JUAN LUIS;MARIN MORAN JUAN LUIS;RUIZ GUTIERREZ JAIME;G...
Nombramientos — 01/09/2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ PARENTE FRANCISCO. Apo.Manc.: PARDO MARTIN JOSE EMILIANO;MARIN MORAN JUAN LUIS;DE LA MAYA VERDE JUAN LUIS;RUIZ GUTIERREZ JAIME;GONZALEZ ROMERO FERNANDO;SAENZ MUÑOZ GONZALO. Datos r...
Ceses/dimisiones — 18/08/2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: GRANDA CAMPO JUAN RAMON. Presidente: GRANDA CAMPO JUAN RAMON. Consejero: SANCHEZ BOTRAN JACINTO. Vicesecret.: VELASCO DIAZ MARIA LUISA. Nombramientos. Consejero: PARDO MARTIN JOSE EMILIANO;D...
Cambio de domicilio social — 18/03/2015
Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL CAMPOLLANO - CALLE AUTOVIA, NUME (ALBACETE). Datos registrales. T 949, L 713, F 105, S 8, H AB 1605, I/A 79 (10.03.15).
Ceses/dimisiones — 23/07/2014
Ceses/Dimisiones. Secretario: GARZARAN LOPEZ JUANA. Nombramientos. SecreNoConsj: GONZALEZ CORREDOR YOLANDA. Datos registrales. T 943, L 707, F 31, S 8, H AB 1605, I/A 76 (16.07.14).
Nombramientos — 24/04/2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ CORCOLES ALBERTO RODOLFO. Apo.Manc.: RIOS MARTINEZ JESUS ANTONIO. Datos registrales. T 936, L 700, F 83, S 8, H AB 1605, I/A 75 (15.04.14).
Reelecciones — 29/11/2013
Reelecciones. Consejero: ROBRES CALVO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 936, L 700, F 83, S 8, H AB 1605, I/A 74 (22.11.13). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 229 Viernes 29 de noviembre de 2013 Pág. 55114 cve...
Ceses/dimisiones — 10/10/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: RIBER GIL JAVIER;PEREZ HERNANDEZ FLORENCIO. Presidente: PEREZ HERNANDEZ FLORENCIO. Nombramientos. Consejero: GRANDA CAMPO JUAN RAMON;SANZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 931, L...
Revocaciones — 10/10/2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ HERNANDEZ FLORENCIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GRANDA CAMPO JUAN RAMON. Apo.Manc.: SANCHEZ BOTRAN JACINTO;MARIN MORAN JUAN LUIS;RUIZ GUTIERREZ JAIME;MORAN MOYA CARLOS. Presidente: GR...
Reelecciones — 10/10/2013
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 936, L 700, F 83, S 8, H AB 1605, I/A 73 ( 3.10.13).
Revocaciones — 16/05/2013
Revocaciones. Apo.Sol.: CALLEJAS GONZALEZ MIGUEL. Datos registrales. T 920, L 684, F 7, S 8, H AB 1605, I/A 69 ( 8.05.13).
Nombramientos — 16/05/2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PARDO MARTIN JOSE EMILIANO. Apo.Manc.: GRANDA CAMPO JUAN RAMON;SANCHEZ BOTRAN JACINTO;DE LA MISERICORDIA GARCIA FERNANDO;RUIZ GUTIERREZ JAIME. Datos registrales. T 920, L 684, F 7, S 8, H AB...
Revocaciones — 17/08/2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALCALDE LOPEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SEBASTIAN BERRENDERO SEBASTIAN. Apo.Manc.: MORAN MOYA CARLOS. Datos registrales. T 920, L 684, F 6, S 8, H AB 1605, I/A 68 ( 7.08.12).
Revocaciones — 18/07/2012
Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ FIDALGO JUAN. Datos registrales. T 519, L 283, F 217, S 8, H AB 1605, I/A 65 ( 9.07.12).
Revocaciones — 18/07/2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ ROMERA JOSE MARIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ HERNANDEZ FLORENCIO. Apo.Manc.: DIAZ DE ESPADA SORIANO IÑIGO;MARIN MORA JUAN LUIS;MORAN MOYA CARLOS. Datos registrales. T 519, L 28...
Revocaciones — 18/07/2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CALLEJAS GONZALEZ MIGUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: CALLEJAS GONZALEZ MIGUEL. Apo.Manc.: PEREZ HERNANDEZ FLORENCIO. Datos registrales. T 920, L 684, F 3, S 8, H AB 1605, I/A 67 ( 9.07.12).
Ceses/dimisiones — 28/06/2012
Ceses/Dimisiones. Presidente: PEREZ ROMERA JOSE MARIA. Consejero: PEREZ ROMERA JOSE MARIA;CELDRAN PEDREÑO VICTORIANO. Nombramientos. Consejero: PEREZ HERNANDEZ FLORENCIO;ESCARDA GELABERT ANTONIO. Presidente: PEREZ HERNA...
Reelecciones — 19/07/2011
Reelecciones. Consejero: RIBER GIL JAVIER. Datos registrales. T 519, L 283, F 217, S 8, H AB 1605, I/A 63 ( 8.07.11).
Ceses/dimisiones — 31/03/2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: MOLINA ALMAZAN AGUSTIN. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: CALLEJAS GONZALEZ MIGUEL. Datos registrales. T 519, L 283, F 217, S 8, H AB 1605, I/A 62 (22.03.11).
Revocaciones — 20/10/2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: COBOS MOLINA FEDERICO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALCALDE LOPEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 519, L 283, F 216, S 8, H AB 1605, I/A 61 ( 7.10.10).
Nombramientos — 17/05/2010
Nombramientos. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 519, L 283, F 215, S 8, H AB BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 92 Lunes 17 de mayo de 2010 Pág. 24304 cve: BORME-A-2010-9...