Actos destacados
Ceses/dimisiones — 10/02/2015
Ceses/Dimisiones. Liquidador: HERRERA RODRIGUEZ DULCE MARIA. Adm. Unico: HERRERA RODRIGUEZ DULCE MARIA. Nombramientos. Liquidador: HERRERA RODRIGUEZ DULCE MARIA. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 3...
Revocaciones — 25/01/2013
Revocaciones. Apoderado: CASTAÑOS RIPOLL MANUEL. Datos registrales. T 3093 , F 163, S 8, H TF 45801, I/A 4 (16.01.13).
Revocaciones — 25/01/2013
Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ GARCIA MARIA JENIFER. Apo.Manc.: GONZALEZ GARCIA MARIA JENIFER;PERDOMO RODRIGUEZ GERARDO. Datos registrales. T 3093 , F 163, S 8, H TF 45801, I/A 5 (16.01.13).
Nombramientos — 17/09/2009
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ GARCIA MARIA JENIFER. Apo.Manc.: GONZALEZ GARCIA MARIA JENIFER;PERDOMO RODRIGUEZ GERARDO. Datos registrales. T 3093 , F 163, S 8, H TF 45801, I/A 3 ( 4.09.09).
Nombramientos — 31/07/2009
Nombramientos. Apoderado: CASTAÑOS RIPOLL MANUEL. Datos registrales. T 3093 , F 162, S 8, H TF 45801, I/A 2 (13.07.09).