Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 21 tarjetas
15/10/2019 Sec. I Cambio de denominación social Guadalajara
Guadalajara-426500

Cambio de denominación social — 15/10/2019

Cambio de denominación social. HIGH INNOVATION ALDOVEA, SL. Datos registrales. T 604 , F 77, S 8, H GU 7116, I/A 26 ( 7.10.19).

09/08/2019 Sec. I Reducción de capital Guadalajara
Guadalajara-349821

Reducción de capital — 09/08/2019

Reducción de capital. Importe reducción: 7.647.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000,00 Euros. Datos registrales. T 604 , F 76, S 8, H GU 7116, I/A 25 (26.07.19).

16/12/2016 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-509623

Nombramientos — 16/12/2016

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CERCADILLO GARCIA JUAN JOSE;SOLANO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER;CATALAN MINGUEZ ELADIO;CATALAN ROMOJARO JUAN;AGUIRRE AGUEDA ALICIA;ALVIR CORDERO LUIS;GANSO MARTINEZ ENRIQUE;GARCIA GARCIA-CONDE...

25/11/2016 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-478843

Nombramientos — 25/11/2016

Nombramientos. Apoderado: GANSO MARTINEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 604 , F 74, S 8, H GU 7116, I/A 23 (15.11.16).

13/09/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Guadalajara
Guadalajara-373837

Ceses/dimisiones — 13/09/2016

Ceses/Dimisiones. Consejero: LAVISIER INVESTMENTS S.L.;STUDIOS CORCOYA III S.L.;HIGH INNOVATION REAL ESTATE S.L. Presidente: HIGH INNOVATION REAL ESTATE S.L. Secretario: GUADALAJARA 2000 S.L. Nombramientos. Consejero: H...

17/04/2015 Sec. I Reducción de capital Guadalajara
Guadalajara-159337

Reducción de capital — 17/04/2015

Reducción de capital. Importe reducción: 350.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 7.650.000,00 Euros. Datos registrales. T 463 , F 6, S 8, H GU 7116, I/A 21 ( 8.04.15).

13/03/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Guadalajara
Guadalajara-109417

Ceses/dimisiones — 13/03/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: CAI INMUEBLES S.A. Datos registrales. T 448 , F 146, S 8, H GU 7116, I/A 20 ( 4.03.15).

31/10/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Guadalajara
Guadalajara-439847

Ceses/dimisiones — 31/10/2014

Ceses/Dimisiones. Consejero: ENCINA LOS MONTEROS S.L.;OCIO LOS MONTEROS S.L. Nombramientos. Consejero: LAVISIER INVESTMENTS S.L.;STUDIOS CORCOYA III S.L. Datos registrales. T 448 , F 145, S 8, H GU 7116, I/A 19 (24.10.1...

18/08/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Guadalajara
Guadalajara-335941

Ceses/dimisiones — 18/08/2014

Ceses/Dimisiones. Consejero: GUIJARRO MARTINEZ LUIS FRANCISCO;GREGORIO DEL CASTILLO SAMPEDRO;AGUIRRE AGUEDA ALICIA. Presidente: GUIJARRO MARTINEZ LUIS FRANCISCO. Secretario: GREGORIO DEL CASTILLO SAMPEDRO. Nombramientos...

11/10/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Guadalajara
Guadalajara-436660

Ceses/dimisiones — 11/10/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: INTERMEDIACION Y PATRIMONIOS S.L.;VALORACION Y CONTROL S.L. Nombramientos. Consejero: ENCINA LOS MONTEROS S.L.;OCIO LOS MONTEROS S.L. Datos registrales. T 442 , F 62, S 8, H GU 7116, I/A 16...

31/05/2011 Sec. I Revocaciones Guadalajara
Guadalajara-231449

Revocaciones — 31/05/2011

Revocaciones. Apo.Manc.: ZORZO CARO MARIA SOLEDAD. Nombramientos. Apo.Manc.: RUIZ SERRANO ELENA. Apoderado: PRIETO DIAZ VANESSA. Datos registrales. T 442 , F 61, S 8, H GU 7116, I/A 14 (18.05.11).

22/02/2011 Sec. I Revocaciones Guadalajara
Guadalajara-79606

Revocaciones — 22/02/2011

Revocaciones. Apo.Manc.: LORA BARBA ROBERTO. Nombramientos. Apo.Sol.: GALLARDO IGLESIAS ASUNCION;ZORZO CARO DAVID;ALCOBA DE LA TORRE JUAN ANTONIO;GOMEZ FERNANDEZ DIEGO. Datos registrales. T 441 , F 82, S 8, H GU 7116, I...

08/02/2011 Sec. I Reelecciones Guadalajara
Guadalajara-55108

Reelecciones — 08/02/2011

Reelecciones. Auditor: DELOITTE S.L. Datos registrales. T 441 , F 82, S 8, H GU 7116, I/A 12 (14.01.11).

30/03/2010 Sec. I Ampliación de capital Guadalajara
Guadalajara-130553

Ampliación de capital — 30/03/2010

Ampliación de capital. Capital: 4.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 441 , F 80, S 8, H GU 7116, I/A 10 (16.03.10).

16/03/2010 Sec. I Reelecciones Guadalajara
Guadalajara-110080

Reelecciones — 16/03/2010

Reelecciones. Auditor: DELOITTE S.L. Datos registrales. T 441 , F 80, S 8, H GU 7116, I/A 9 (26.02.10).

02/06/2009 Sec. I Otros conceptos: Cambio de representante persona física en el cargo de consejero que ostenta la sociedad Valorción y Control, S Guadalajara
Guadalajara-250501

Otros conceptos: cambio de representante persona física en el cargo de consejero que ostenta la sociedad valorción y control, s — 02/06/2009

Otros conceptos: Cambio de representante persona física en el cargo de consejero que ostenta la sociedad Valorción y Control, S.L., nombrándose a Don Alfonso Javier Cejudo Sánchez. Datos registrales. T 441 , F 80, S 8,...

03/03/2009 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-109612

Nombramientos — 03/03/2009

Nombramientos. Auditor: DELOITTE S.L. Ampliación de capital. Capital: 3.488.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 519 , F 185, S 8, H GU 7116, I/A 7 (20.02.09). http://www.boe.es BO...

18/02/2009 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-86658

Nombramientos — 18/02/2009

Nombramientos. Consejero: INTERMEDIACION Y PATRIMONIOS S.L.;VALORACION Y CONTROL S.L. Datos registrales. T 519 , F 184, S 8, H GU 7116, I/A 5 ( 4.02.09).

18/02/2009 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-86659

Nombramientos — 18/02/2009

Nombramientos. Consejero: CAI INMUEBLES S.A. Datos registrales. T 519 , F 184, S 8, H GU 7116, I/A 4 ( 4.02.09).

18/02/2009 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-86660

Nombramientos — 18/02/2009

Nombramientos. Apo.Manc.: CERCADILLO CALVO JUAN JOSE;CERCADILLO CALVO MONTSERRAT;GUIJARRO MARTINEZ LUIS FRANCISCO;MARIA JOSE PALMA GUTIERREZ;ESPLIEGO MONEDERO LAURA;ZORZO CARO MARIA SOLEDAD;AGUIRRE AGUEDA ALICIA;LORA BA...

13/01/2009 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-15969

Nombramientos — 13/01/2009

Nombramientos. Apoderado: GUIJARRO MARTINEZ LUIS FRANCISCO. Datos registrales. T 519 , F 183, S 8, H GU 7116, I/A 3 ( 3.12.08).