Actos destacados
Declaración de unipersonalidad — 17/07/2017
Declaración de unipersonalidad. Socio único: COMIS LAGUN SL. Datos registrales. T 5465, L 4372, F 3, S 8, H MA102460, I/A 29 ( 6.07.17).
Modificaciones estatutarias — 23/09/2016
Modificaciones estatutarias. 18. Miembros, Duración y Retribución.-. Cambio de domicilio social. C/ MARACAY 5 - NAVE 96/A2, POLIGONO INDUSTRIAL DE (MALAGA). Datos registrales. T 5465, L 4372, F 93, S 8, H MA102460, I/A...
Nombramientos — 02/06/2016
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ ORTIZ MARIA. Datos registrales. T 5465, L 4372, F 1, S 8, H MA102460, I/A 25 (24.05.16).
Nombramientos — 02/06/2016
Nombramientos. Apoderado: ERAÑA URIARTE MIREN MAITE. Datos registrales. T 5465, L 4372, F 2, S 8, H MA102460, I/A 26 (25.05.16).
Nombramientos — 02/06/2016
Nombramientos. Apoderado: TARREGA JUAN MARIA CONSUELO. Datos registrales. T 5465, L 4372, F 2, S 8, H MA102460, I/A 27 (25.05.16).
Ceses/dimisiones — 29/12/2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CANELA MALAGA SL. Nombramientos. Adm. Unico: AUZO LAGUN S COOP. Datos registrales. T 4676, L 3584, F 46, S 8, H MA102460, I/A 21 (21.12.15).
Revocaciones — 29/12/2015
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ FRANCO JUAN MANUEL;MARTIN FERNANDEZ ANA. Datos registrales. T 4676, L 3584, F 46, S 8, H MA102460, I/A 22 (21.12.15).
Nombramientos — 29/12/2015
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA. Datos registrales. T 4676, L 3584, F 46, S 8, H MA102460, I/A 23 (21.12.15).
Nombramientos — 29/12/2015
Nombramientos. Apoderado: HUERTAS CLARAMONTE PEDRO. Datos registrales. T 4676, L 3584, F 47, S 8, H MA102460, I/A 24 (21.12.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 247 Martes 29 de diciembre de 2015 Pág. 56902...
Ceses/dimisiones — 17/09/2015
Ceses/Dimisiones. Secretario: TRIGUERO FLORIDO REYES. Consejero: LARA GRACIAN JUAN ANTONIO. Presidente: LARA GRACIAN JUAN ANTONIO. Consejero: CANELA MALAGA SL. Con.Delegado: LARA GRACIAN JUAN ANTONIO. Nombramientos. Adm...
Ceses/dimisiones — 07/08/2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: ARCOS MOYA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 4676, L 3584, F 45, S 8, H MA102460, I/A 19 (30.07.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 149 Viernes 7 de agosto de 2015 Pág. 35610 c...
Nombramientos — 29/06/2015
Nombramientos. Auditor: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SAP. Datos registrales. T 4676, L 3584, F 45, S 8, H MA102460, I/A 18 (18.06.15).
Nombramientos — 16/10/2014
Nombramientos. Auditor: REDING AUDITORES SL. Datos registrales. T 4676, L 3584, F 45, S 8, H MA102460, I/A 17 ( 3.10.14).
Reelecciones — 08/11/2012
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4676, L 3584, F 45, S 8, H MA102460, I/A 15 (25.10.12).
Nombramientos — 23/08/2012
Nombramientos. Apoderado: MARTIN FERNANDEZ ANA. Datos registrales. T 4676, L 3584, F 44, S 8, H MA102460, I/A 13 ( 8.08.12).
Revocaciones — 02/01/2012
Revocaciones. Apoderado: MARTIN PADILLA JOSE. Datos registrales. T 4676, L 3584, F 44, S 8, H MA102460, I/A 11 (20.12.11).
Nombramientos — 21/10/2011
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ FRANCO JUAN MANUEL. Datos registrales. T 4676, L 3584, F 43, S 8, H MA102460, BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 201 Viernes 21 de octubre de 2011 Pág. 59395 cve: BORME-A-201...
Constitución — 09/09/2009
Constitución. Comienzo de operaciones: 7.08.09. Objeto social: Creación, adquisición o participación y explotación de empresas turísticas, bares, cafeterías, restaurantes, comedores industriales y de colectividades, cat...