Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2015 4 tarjetas
03/12/2015 Sec. I Declaración de unipersonalidad Madrid
Madrid-491262

Declaración de unipersonalidad — 03/12/2015

Declaración de unipersonalidad. Socio único: VOUSSE CLINICAS MEDICO ESTETICAS SL. Ceses/Dimisiones. Representan: PEREZ BEATO BELLO MARIA CELIA;CARBO FERNANDEZ CARLOS. Secretario: SANGRO GOMEZ ACEBO PEDRO. VsecrNoConsj:...

24/09/2015 Sec. I Reducción de capital Madrid
Madrid-387082

Reducción de capital — 24/09/2015

Reducción de capital. Importe reducción: 840.241,98 Euros. Resultante Suscrito: 63.244,02 Euros. Datos registrales. T 20605 , F 216, S 8, H M 364784, I/A 28 (11.09.15).

18/02/2014 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-76130

Reelecciones — 18/02/2014

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 20605 , F 214, S 8, H M 364784, I/A 26 (10.02.14).

02/08/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-347566

Ceses/dimisiones — 02/08/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: CARBO FERNANDEZ CARLOS;PEREZ BEATO BELLO MARIA CELIA. Con.Delegado: CARBO FERNANDEZ CARLOS. Presidente: CARBO FERNANDEZ CARLOS. Nombramientos. Representan: PEREZ BEATO BELLO MARIA CELIA;CARB...