Actos destacados
Situación concursal — 27/04/2017
Situación concursal. Procedimiento concursal 103/2017. FIRME: No, Fecha de resolución 22/03/2017. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 DE LO MERCANTIL DE PAMPLONA. Juez: VICTORIA RUBIO JIMENEZ. R...
Declaración de unipersonalidad — 27/03/2017
Declaración de unipersonalidad. Socio único: EDIFICACIONES NUEVO EZCABA SL. Datos registrales. T 1656 , F 144, S 8, H NA 6772, I/A 101 (15.03.17).
Ceses/dimisiones — 27/03/2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DHO INFRAESTRUCTURAS SL. Nombramientos. Adm. Unico: ALONSO RAMOS JOSE LUIS. Datos registrales. T 1656 , F 144, S 8, H NA 6772, I/A 102 (16.03.17). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm...
Otros conceptos: ratificado el nombramiento de don alfonso navarro peromingo como representante físico del administrador único — 11/08/2016
Otros conceptos: Ratificado el nombramiento de Don Alfonso Navarro Peromingo como representante físico del administrador único. Datos registrales. T 1656 , F 143, S 8, H NA 6772, I/A 98 ( 3.08.16). BOLETÍN OFICIAL DEL R...
Reducción de capital — 14/12/2015
Reducción de capital. Importe reducción: 1.177.961,46 Euros. Resultante Suscrito: 4.782.953,72 Euros. Datos registrales. T 1656 , F 143, S 8, H NA 6772, I/A 97 ( 1.12.15).
Nombramientos — 10/09/2015
Nombramientos. Apoderado: SESMA GIL ANTONIO PASCUAL;COLMENAR CARRO FEDERICO ROMAN;RODRIGUEZ SALVANES CARLOS;SOLA GOMARA RAQUEL PILAR. Datos registrales. T 1656 , F 142, S 8, H NA 6772, I/A 96 (27.08.15).
Reelecciones — 21/05/2015
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1656 , F 142, S 8, H NA 6772, I/A 95 ( 4.05.15).
Reelecciones — 07/11/2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1656 , F 142, S 8, H NA 6772, I/A 94 (28.10.14).
Pérdida del caracter de unipersonalidad — 24/04/2014
Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ampliación de capital. Suscrito: 5.737.338,68 Euros. Desembolsado: 5.737.338,68 Euros. Resultante Suscrito: 5.960.915,18 Euros. Resultante Desembolsado: 5.960.915,18 Euros. Datos...
Nombramientos — 24/04/2014
Nombramientos. Apoderado: BURRIEZA GOMEZ VICTOR JOSE;CEREZO LALLANA ALVARO. Datos registrales. T 1656 , F 140, S 8, H NA 6772, I/A 92 (11.04.14).
Revocaciones — 24/04/2014
Revocaciones. Apoderado: ROSELLO ESTEBAN PEDRO. Datos registrales. T 1656 , F 142, S 8, H NA 6772, I/A 93 (11.04.14).
Ceses/dimisiones — 01/03/2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DHO INFRAESTRUCTURAS SA. Nombramientos. Adm. Unico: DHO INFRAESTRUCTURAS SL. Otros conceptos: Cambiada la forma social del socio único de la entidad de esta hoja, pasando de ser una socieda...
Revocaciones — 25/02/2013
Revocaciones. Apoderado: NIETO GIMENEZ JOSE MARIA;PALACIOS BLANCO PEDRO;NAVARRO PEROMINGO ALFONSO;VILLEGAS GARCIA MORENO JESUS REYES;MENDEZ GORBEA ANA;POZA CEBALLOS FELIX ANGEL;SANCHEZ BALBAS IGNACIO;NUÑEZ JARAMILLO ANT...
Nombramientos — 25/02/2013
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ SALVANES CARLOS. Datos registrales. T 1306 , F 25, S 8, H NA 6772, I/A 86 (15.02.13).
Reelecciones — 25/02/2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1306 , F 26, S 8, H NA 6772, I/A 87 (15.02.13).
Cambio de domicilio social — 25/02/2013
Cambio de domicilio social. C/ EMPRESARIAL LA ESTRELLA, CALLE BERROA 4 - OFICI (ARANGUREN). Datos registrales. T 1306 , F 26, S 8, H NA 6772, I/A 88 (15.02.13).
Nombramientos — 25/02/2013
Nombramientos. Apoderado: COLMENAR CARRO FEDERICO. Datos registrales. T 1306 , F 26, S 8, H NA 6772, I/A 89 (15.02.13). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 38 Lunes 25 de febrero de 2013 Pág. 9792 cve: BORME-A-2...
Nombramientos — 17/05/2012
Nombramientos. Apoderado: ROSELLO ESTEBAN PEDRO. Datos registrales. T 1306 , F 23, S 8, H NA 6772, I/A 84 ( 7.05.12). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Revocaciones — 30/04/2012
Revocaciones. Apoderado: ROMERALES CIDONCHA ANDRES MIGUEL;GONZALEZ DIAZ ANGEL LUIS;NUÑEZ JARAMILLO ANTONIO;SESMA GIL ANTONIO PASCUAL;POZA CEBALLOS FELIX ANGEL;DE DIEGO GARCIA FERNANDO;RODRIGUEZ DE COLMENARES ALVAREZ FER...
Reelecciones — 28/03/2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1306 , F 22, S 8, H NA 6772, I/A 82 (15.03.12).
Reelecciones — 26/10/2010
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1306 , F 22, S 8, H NA006772, I/A00081 (15.10.10).
Nombramientos — 06/09/2010
Nombramientos. Apoderado: SESMA GIL ANTONIO PASCUAL. Datos registrales. T 1306 , F 21, S 8, H NA006772, I/A00079 (24.08.10).
Nombramientos — 26/05/2009
Nombramientos. Apoderado: SESMA GIL ANTONIO PASCUAL. Datos registrales. T 1306 , F 20, S 8, H NA006772, I/A00077 (14.05.09).
Revocaciones — 26/05/2009
Revocaciones. Apoderado: MENDEZ OLIVA BENIGNO;ALMOGUERA SANCHEZ-VILLACAÑAS SANTIAGO. Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ SALVANES CARLOS. Datos registrales. T 1306 , F 21, S 8, H NA006772, I/A00078 (14.05.09). BOLETÍN O...