Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 5 tarjetas
19/04/2018 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-172432

Cambio de domicilio social — 19/04/2018

Cambio de domicilio social. C/ HIERRO 32 (TORREJON DE ARDOZ). Datos registrales. T 37485 , F 102, S 8, H M 668179, I/A 2 (11.04.18).

15/02/2017 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-74027

Nombramientos — 15/02/2017

Nombramientos. APODERAD.SOL: MIGUEL CORBILLO JOSE ANTONIO;VALLES PEREZ MERCEDES. Datos registrales. T 43576 , F 162, S 8, H B 100110, I/A 27 ( 3.02.17).

20/02/2013 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-83960

Nombramientos — 20/02/2013

Nombramientos. APODERADO: VALLES PEREZ MERCEDES. Datos registrales. T 36247 , F 69, S 8, H B 100110, I/A 20 (12.02.13).

20/02/2013 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-83968

Nombramientos — 20/02/2013

Nombramientos. APODERADO: MARTIN ZAFRA MARIA LOURDES. Datos registrales. T 36247 , F 70, S 8, H B 100110, I/A 21 (12.02.13).

20/02/2013 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-83976

Nombramientos — 20/02/2013

Nombramientos. APODERADO: MIGUEL CORBILLO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 36247 , F 70, S 8, H B 100110, I/A 22 (12.02.13).