Actos destacados
Modificaciones estatutarias — 14/06/2018
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6. Datos registrales. T 2265 , F 143, S 8, H CO 1696, I/A 140 ( 7.06.18).
Reelecciones — 05/02/2018
Reelecciones. Adm. Unico: ROMERO GONZALEZ JOSE. Datos registrales. T 2265 , F 143, S 8, H CO 1696, I/A 139 (29.01.18).
Nombramientos — 30/01/2018
Nombramientos. Auditor: AUDIBALANCE SLP. Aud.C.Con.: AUDIBALANCE SLP. Datos registrales. T 2265 , F 142, S 8, H CO 1696, I/A 138 (22.01.18).
Cambio de domicilio social — 17/04/2017
Cambio de domicilio social. C/ SAN ALVARO 2 ENTREPLA (CORDOBA). Datos registrales. T 2265 , F 142, S 8, H CO 1696, I/A 137 ( 6.04.17).
Modificaciones estatutarias — 07/02/2017
Modificaciones estatutarias. 12.B. Organización de la administración de la sociedad.-. Datos registrales. T 2265 , F 142, S 8, H CO 1696, I/A 136 (31.01.17).
Revocaciones — 11/11/2016
Revocaciones. Apoderado: TIRADO LOPEZ JOSE;TIRADO LOPEZ JOSE;ROMERO GONZALEZ CELEDONIO;ORIZAOLA PAZ ENRIQUE CARLOS FRANCISCO;FERNANDEZ BERCHEZ CARLOS;MARQUEZ PASTOR ANTONIO;MARQUEZ PASTOR ANTONIO;FERNANDEZ BERCHEZ CARLO...
Reducción de capital — 24/10/2016
Reducción de capital. Importe reducción: 76.772.576,95 Euros. Resultante Suscrito: 10.846.909,75 Euros. Datos registrales. T 2265 , F 138, S 8, H CO 1696, I/A 133 (17.10.16). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGIST...
Revocaciones — 14/06/2016
Revocaciones. Apoderado: GADEA RAMOS MARIA LOURDES. Datos registrales. T 2265 , F 139, S 8, H CO 1696, I/A 132 ( 7.06.16).
Fusión por unión — 03/03/2016
Fusión por unión. Sociedades que se fusiónan: PRASA EJECUCION DE OBRAS SL. OUTSOURCING SEGUROS DE CORDOBA NORTE SL. ESPACIO TURISTICO SOSTENIBLE SIERRA DE LA MOTA SL. PRASA CANARIAS SL. BENALUA SUR, SL. ARRENDAMIENTOS E...
Revocaciones — 22/12/2015
Revocaciones. Apoderado: CAMPANERO BRETONES MANUEL. Datos registrales. T 2265 , F 134, S 8, H CO 1696, I/A 130 (15.12.15).
Revocaciones — 31/03/2015
Revocaciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE AUDITORIA SA. Nombramientos. Auditor: ALCALA ZAMORA BARRON LUIS. Aud.Supl.: AGUERA JIMENEZ JUAN. Datos registrales. T 2265 , F 133, S 8, H CO 1696, I/A 129 (25.03.15).
Nombramientos — 19/11/2014
Nombramientos. Apoderado: CANO CABANILLAS RAQUEL. Datos registrales. T 2265 , F 133, S 8, H CO 1696, I/A 128 (13.11.14).
Revocaciones — 22/07/2014
Revocaciones. Apoderado: GENTIL ALCOBENDAS FRANCISCO;GENTIL ALCOBENDAS FRANCISCO. Datos registrales. T 2265 , F 132, S 8, H CO 1696, I/A 127 (16.07.14).
Nombramientos — 16/06/2014
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ CARRASCO JULIO. Datos registrales. T 2265 , F 132, S 8, H CO 1696, I/A 126 ( 9.06.14).
Reducción de capital — 12/05/2014
Reducción de capital. Importe reducción: 100.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 87.619.486,70 Euros. Datos registrales. T 2265 , F 131, S 8, H CO 1696, I/A 125 ( 5.05.14).
Nombramientos — 06/02/2013
Nombramientos. Auditor: ESPAUDIT GABINETE AUDITORIA SA. Datos registrales. T 2265 , F 131, S 8, H CO 1696, I/A 124 (30.01.13).
Revocaciones — 15/11/2012
Revocaciones. Auditor: AUDIBALANCE SL. Datos registrales. T 2265 , F 131, S 8, H CO 1696, I/A 123 ( 5.11.12).
Nombramientos — 17/02/2012
Nombramientos. Apo.Manc.: ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS;ROMERO GONZALEZ PABLO;ROMERO GONZALEZ JUANA;JORDAN CRESPO TEODOSIO ANTONIO. Datos registrales. T 1549 , F 225, S 8, H CO 1696, I/A 122 ( 8.02.12).
Ceses/dimisiones — 13/02/2012
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS. Consejero: ROMERO GONZALEZ JUANA;ROMERO GONZALEZ JOSE. Presidente: ROMERO GONZALEZ JOSE. Consejero: ROMERO GONZALEZ PABLO;ROMERO GONZALEZ CELEDONIO;ROMERO GONZ...
Reelecciones — 22/11/2011
Reelecciones. Auditor: AUDIBALANCE SL. Datos registrales. T 1549 , F 224, S 8, H CO 1696, I/A 119 (10.11.11).
Ceses/dimisiones — 30/08/2011
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CRIADO BLANCO INMACULADA. Nombramientos. SecreNoConsj: AMAYA GALVAN JOAQUIN ENRIQUE. Datos registrales. T 1549 , F 223, S 8, H CO 1696, I/A 118 (19.08.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO ME...
Nombramientos — 22/07/2011
Nombramientos. Apoderado: LEON GALVIN RAFAEL. Datos registrales. T 1549 , F 223, S 8, H CO 1696, I/A 117 (14.07.11).
Nombramientos — 07/07/2011
Nombramientos. Apoderado: GENTIL ALCOBENDAS FRANCISCO. Datos registrales. T 1549 , F 222, S 8, H CO 1696, I/A 116 (28.06.11).
Nombramientos — 24/11/2010
Nombramientos. Apo.Sol.: MUÑOZ FERNANDEZ MARIA JOSE;CASADO PRADO GUILLERMO. Datos registrales. T 1549 , F 221, S 8, H CO 1696, I/A 115 (15.11.10). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/19...