Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 5 tarjetas
21/12/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-516860

Revocaciones — 21/12/2016

Revocaciones. Apoderado: OLARREAGA YEREGUI JOSE. Datos registrales. T 20272 , F 217, S 8, H M 358312, I/A 12 (14.12.16).

11/02/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-62584

Revocaciones — 11/02/2016

Revocaciones. Apoderado: XERCAVINS LLUCH JOSE MARIA;BOSCH PUJOL PERE;REGALADO CORISCO ANTONIO CESAR;GIMENEZ CERVANTES MIGUEL JOSE. Datos registrales. T 20272 , F 215, S 8, H M 358312, I/A 10 ( 4.02.16).

08/02/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-55677

Ceses/dimisiones — 08/02/2016

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: REGALADO CORISCO ANTONIO CESAR;GIMENEZ CERVANTES MIGUEL JOSE. Nombramientos. Adm. Unico: ANTONUCCI GAETE ENRIQUE. Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 16 DE LOS ESTATUTOS SO...

08/02/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-55678

Nombramientos — 08/02/2016

Nombramientos. Apoderado: OLARREAGA YEREGUI JOSE. Datos registrales. T 20272 , F 214, S 8, H M 358312, I/A 9 (29.01.16).

15/10/2012 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-418514

Cambio de domicilio social — 15/10/2012

Cambio de domicilio social. C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 17 Esc.A 2º - DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 20272 , F 213, S 8, H M 358312, I/A 5 ( 3.10.12).