Actos destacados
Nombramientos — 11/12/2019
Nombramientos. Apoderado: DAVID GARCIA MARTIN. Datos registrales. T 227 , F 107, S 8, H SG 1505, I/A 25 (28.11.19).
Nombramientos — 14/11/2019
Nombramientos. Auditor: AUDRIA SL. Datos registrales. T 227 , F 107, S 8, H SG 1505, I/A 24 ( 7.11.19).
Declaración de unipersonalidad — 23/10/2019
Declaración de unipersonalidad. Socio único: INVERSIONES MENCIA SL. Reducción de capital. Importe reducción: 125.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 506.900,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los Estatuto...
Ceses/dimisiones — 10/06/2019
Ceses/Dimisiones. Secretario: JOSE MANUEL GUEDE FERNANDEZ. Consejero: JOSE MANUEL GUEDE FERNANDEZ. Presidente: CORTES PERSIVA MANUEL. Consejero: CORTES PERSIVA MANUEL. Con.Delegado: CORTES CORRIPIO MANUEL. Consejero: CO...
Revocaciones — 10/06/2019
Revocaciones. Apoderado: JOSE MANUEL GUEDE FERNANDEZ. Datos registrales. T 227 , F 106, S 8, H SG 1505, I/A 22 ( 3.06.19).
Nombramientos — 05/01/2017
Nombramientos. Auditor: AUDRIA SL. Datos registrales. T 227 , F 106, S 8, H SG 1505, I/A 20 (27.12.16).
Pérdida del caracter de unipersonalidad — 29/06/2015
Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CORTES PERSIVA MANUEL. Nombramientos. Consejero: CORTES CORRIPIO MANUEL;CORTES PERSIVA, MANUEL;JOSE MANUEL GUEDE FERNANDEZ. Presidente: CORTES PERSI...
Ceses/dimisiones — 18/06/2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CORTES CORRIPIO MANUEL. Nombramientos. Adm. Unico: CORTES PERSIVA, MANUEL. Cambio de objeto social. Fabricación, distribución, importación, exportación y venta de: Estructurade nido de abej...
Nombramientos — 18/06/2013
Nombramientos. Apoderado: CORTES CORRIPIO MANUEL. Datos registrales. T 227 , F 104, S 8, H SG 1505, I/A 18 (11.06.13).
Revocaciones — 23/04/2013
Revocaciones. Apoderado: GUEDE FERNANDEZ, JOSE-MANUEL. Nombramientos. Apoderado: JOSE MANUEL GUEDE FERNANDEZ. Datos registrales. T 227 , F 103, S 8, H SG 1505, I/A 16 (16.04.13). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL RE...
Reducción de capital — 11/09/2012
Reducción de capital. Importe reducción: 2.787.300,00 Euros. Resultante Suscrito: 632.700,00 Euros. Datos registrales. T 227 , F 102, S 8, H SG 1505, I/A 15 (31.08.12).
Adaptación de sociedad — 28/12/2011
Adaptación de sociedad. Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PAREJO GAMIR ROBERTO. Vicepresid.: CORTES PERSIVA MANUEL. Consejero: CORTES PERSIVA MANUEL. Presidente: FERNANDEZ AGUDO EDUARDO. Consejero: FERNANDEZ AGUDO EDUARDO...
Ampliación de capital — 21/06/2010
Ampliación de capital. Capital: 800.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.420.000,00 Euros. Datos registrales. T 227 , F 101, S 8, H SG 1505, I/A 13 (10.06.10).
Nombramientos — 26/03/2009
Nombramientos. Apoderado: GUEDE FERNANDEZ JOSE-MANUEL. Datos registrales. T 227 , F 100, S 8, H SG 1505, I/A 12 (13.03.09).
Nombramientos — 11/03/2009
Nombramientos. Auditor: LAVINIA A.C.G. AUDITORES SL. Datos registrales. T 227 , F 100, S 8, H SG 1505, I/A 11 ( 2.03.09).