Actos destacados
Ceses/dimisiones — 22/12/2017
Ceses/Dimisiones. Auditor: JUAN PEREZ CONESA. Aud.Supl.: ANGEL SANCHEZ MARTINEZ. Nombramientos. Auditor: JPC CONSULTORES Y AUDITORES SL. Datos registrales. T 1260 , F 148, S 8, H MU 1367, I/A 17 (15.12.17).
Nombramientos — 02/06/2017
Nombramientos. Apoderado: MARIA ENCARNACION MARTINEZ BAEZA. Datos registrales. T 1260 , F 148, S 8, H MU 1367, I/A 16 (26.05.17).
Nombramientos — 20/04/2017
Nombramientos. Apoderado: ENCARNACION MARTINEZ BAEZA. Datos registrales. T 1260 , F 148, S 8, H MU 1367, I/A 15 (11.04.17).
Otros conceptos: modificacion del articulo 24 referente a la retribucion de los administradores — 14/09/2016
Otros conceptos: MODIFICACION DEL ARTICULO 24 REFERENTE A LA RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES. Datos registrales. T 1260 , F 147, S 8, H MU 1367, I/A 14 ( 7.09.16).
Reducción de capital — 03/03/2016
Reducción de capital. Importe reducción: 61.398,15 Euros. Resultante Suscrito: 546.405,39 Euros. Escisión parcial. Sociedades beneficiarias de la escisión: AGROMARTINEZ 2015, S.L. Datos registrales. T 1260 , F 147, S 8,...
Nombramientos — 11/02/2016
Nombramientos. Auditor: JUAN PEREZ CONESA. Aud.Supl.: ANGEL SANCHEZ MARTINEZ. Datos registrales. T 1260 , F 147, S 8, H MU 1367, I/A 12 ( 4.02.16).
Nombramientos — 25/08/2014
Nombramientos. Auditor: ANGEL SANCHEZ MARTINEZ. Aud.Supl.: JUAN PEREZ CONESA. Datos registrales. T 1260 , F 147, S 8, H MU 1367, I/A 11 (18.08.14).
Nombramientos — 01/10/2013
Nombramientos. Auditor: ANGEL SANCHEZ MARTINEZ;FERNANDO MARTINEZ LOPEZ. Datos registrales. T 1260 , F 147, S 8, H MU 1367, I/A 10 (24.09.13).