Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 13 tarjetas
08/11/2019 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-462748

Nombramientos — 08/11/2019

Nombramientos. Consejero: XHIWU XU. Datos registrales. T 36262 , F 207, S 8, H M 591870, I/A 17 ( 3.11.19).

12/07/2019 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-301309

Nombramientos — 12/07/2019

Nombramientos. Apoderado: MARTIN GIMENO PEDRO. Datos registrales. T 36262 , F 205, S 8, H M 591870, I/A 16 ( 5.07.19).

11/07/2019 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-298688

Nombramientos — 11/07/2019

Nombramientos. Consejero: MARTIN GIMENO PEDRO;MARTINAVARRO FERRER ENRIQUE;VIEJO-FLUITERS XIMENEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 36262 , F 204, S 8, H M 591870, I/A 14 ( 4.07.19).

11/07/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-298689

Ceses/dimisiones — 11/07/2019

Ceses/Dimisiones. Consejero: TINMAR 1973 SL;206 WORKS SL. Cons.Del.Man: TINMAR 1973 SL;206 WORKS SL. Presidente: TINMAR 1973 SL. Consejero: MARTIN GIMENO PEDRO. Representan: MARTINEZ ROVIRA MARTIN;MARTINEZ ROVIRA JOSE-...

08/07/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-292680

Ceses/dimisiones — 08/07/2019

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINAVARRO FERRER ENRIQUE. Modificaciones estatutarias. Creación del articulo 20 bis y 29 bis. Datos registrales. T 36262 , F 203, S 8, H M 591870, I/A 13 ( 1.07.19).

19/03/2019 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-124909

Nombramientos — 19/03/2019

Nombramientos. Consejero: WANG GUORONG. Datos registrales. T 36262 , F 203, S 8, H M 591870, I/A 12 (13.03.19).

26/04/2018 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-183558

Cambio de domicilio social — 26/04/2018

Cambio de domicilio social. C/ SERRANO, 67, 2ª PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 36262 , F 203, S 8, H M 591870, I/A 11 (19.04.18).

19/02/2018 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-80417

Ampliación de capital — 19/02/2018

Ampliación de capital. Capital: 353,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.353,00 Euros. Datos registrales. T 36262 , F 202, S 8, H M 591870, I/A 10 ( 9.02.18).

10/01/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-12917

Ceses/dimisiones — 10/01/2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: VIEJO-FLUITERS XIMENEZ ENRIQUE. Vicesecret.: VIEJO-FLUITERS XIMENEZ ENRIQUE. Con.Delegado: VIEJO-FLUITERS XIMENEZ ENRIQUE. Consejero: VIEJO MADRAZO MIGUEL;MARTINEZ ROVIRA MARTIN;ZARZA GARCIA...

04/05/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-192012

Nombramientos — 04/05/2016

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ROVIRA MARTIN;CELDRAN ROMERO MARIO;VIEJO-FLUITERS XIMENEZ ENRIQUE;VIEJO MADRAZO MIGUEL;ALVARO ZARZA GARCIA;RESUSTA COVARRUBIAS IÑIGO. Datos registrales. T 32876 , F 57, S 8, H M 591870...

09/07/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-282183

Ceses/dimisiones — 09/07/2015

Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MARTINEZ ROVIRA MARTIN;VIEJO-FLUITERS XIMENEZ ENRIQUE;CELDRAN ROMERO MARIO;VIEJO MADRAZO MIGUEL. Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ ROVIRA JOSE-ANTONIO. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ...

09/12/2014 Sec. I Constitución Madrid
Madrid-500670

Constitución — 09/12/2014

Constitución. Comienzo de operaciones: 16.10.14. Objeto social: LA INVESTIGACION, FABRICACION, DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE SISTEMAS ENERGETICOS MEDIANTE EL USO DE MATERIALES NANOTECNOLOGICOS... Domicilio: C/ ZURBAN...

09/12/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-500671

Nombramientos — 09/12/2014

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ROVIRA JOSE-ANTONIO. Datos registrales. T 32876 , F 52, S 8, H M 591870, I/A 2 ( 1.12.14).