Actos destacados
Cambio de denominación social — 12/02/2018
Cambio de denominación social. GONVAUTO GALICIA SA. Datos registrales. T 3459, L 3459, F 41, S 8, H PO 32640, I/A 42 ( 2.02.18).
Revocaciones — 15/01/2018
Revocaciones. Apoderado: IZU VIÑUALES JAVIER. Datos registrales. T 3459, L 3459, F 40, S 8, H PO 32640, I/A 40 ( 4.01.18).
Nombramientos — 15/01/2018
Nombramientos. Apoderado: LUACES BASOA SUSANA. Datos registrales. T 3459, L 3459, F 40, S 8, H PO 32640, I/A 41 ( 4.01.18).
Reelecciones — 03/01/2017
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3459, L 3459, F 40, S 8, H PO 32640, I/A 38 (23.12.16).
Ceses/dimisiones — 17/11/2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: CALVO MOREIRA JESUS. Secretario: CALVO MOREIRA JESUS. Nombramientos. Consejero: RUIZ ESCRIBANO MARIO. Secretario: RUIZ ESCRIBANO MARIO. Datos registrales. T 3459, L 3459, F 39, S 8, H PO 326...
Reelecciones — 15/01/2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3459, L 3459, F 39, S 8, H PO 32640, I/A 36 ( 8.01.16).
Otros conceptos: se modifica la retribucion para el organo de administracion y, en consecuencia, se modifica la redaccion del articulo 17º de los estatutos sociales — 09/03/2015
Otros conceptos: SE MODIFICA LA RETRIBUCION PARA EL ORGANO DE ADMINISTRACION Y, EN CONSECUENCIA, SE MODIFICA LA REDACCION DEL ARTICULO 17º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 3459, L 3459, F 39, S 8, H PO 32...
Reelecciones — 26/12/2014
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3459, L 3459, F 39, S 8, H PO 32640, I/A 34 (17.12.14).
Revocaciones — 28/02/2014
Revocaciones. Apoderado: BALZA ECHEITA ANA ICIAR. Datos registrales. T 3459, L 3459, F 39, S 8, H PO 32640, I/A 33 (19.02.14).
Reelecciones — 24/01/2014
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3459, L 3459, F 38, S 8, H PO 32640, I/A 32 (16.01.14).
Nombramientos — 12/07/2013
Nombramientos. Apoderado: IZU VIÑUALES JAVIER. Datos registrales. T 3459, L 3459, F 37, S 8, H PO 32640, I/A 29 ( 4.07.13).
Otros conceptos: se establece retribución para el órgano de administración — 05/07/2013
Otros conceptos: Se establece retribución para el órgano de administración. Datos registrales. T 3459, L 3459, F 37, S 8, H PO 32640, I/A 28 (28.06.13).
Reelecciones — 22/01/2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3459, L 3459, F 36, S 8, H PO 32640, I/A 27 (14.01.13).
Modificaciones estatutarias — 29/03/2012
Modificaciones estatutarias. "ARTICULO 17 .- COMPOSICION, PROHIBICIONES Y RETRIBUCION: La sociedad estará regida y administrada por un Consejo de Administración, compuesto por tres miembros como mínimo y siete como máxi...
Reelecciones — 06/02/2012
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3459, L 3459, F 36, S 8, H PO 32640, I/A 25 (25.01.12).
Ceses/dimisiones — 19/09/2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: RIBERAS MERA FRANCISCO JOSE. Cons.Del.Sol: RIBERAS MERA FRANCISCO JOSE. Nombramientos. Consejero: HOLDING GONVARRI SL. Datos registrales. T 3459, L 3459, F 36, S 8, H PO 32640, I/A 24 ( 6.09...
Nombramientos — 26/08/2011
Nombramientos. Apoderado: CALVO MOREIRA JESUS. Apo.Manc.: CALVO MOREIRA JESUS;BAZAGA GONZALEZ FRANCISCO;RUIZ ESCRIBANO MARIO. Apoderado: BAZAGA GONZALEZ FRANCISCO. Apo.Manc.: CALVO MOREIRA JESUS;BAZAGA GONZALEZ FRANCISC...
Revocaciones — 26/08/2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PAJARES SANCHEZ VALIENTE CARLOS. Apo.Manc.: CALVO MOREIRA JESUS;IMAZ RUBALCABA JAVIER. Apo.Man.Soli: IMAZ RUBALCABA JAVIER;CALVO MOREIRA JESUS. Apo.Manc.: IMAZ RUBALCABA JAVIER;CALVO MOREIRA...
Ceses/dimisiones — 26/08/2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: RIBERAS MERA JUAN MARIA. Secretario: RIBERAS MERA JUAN MARIA. Cons.Del.Sol: RIBERAS MERA JUAN MARIA. Nombramientos. Consejero: CALVO MOREIRA JESUS. Secretario: CALVO MOREIRA JESUS. Datos reg...
Modificaciones estatutarias — 19/07/2010
Modificaciones estatutarias. "ARTICULO 17. COMPOSICION. PROHIBICIONES Y RETRIBUCION": "La sociedad estará regida y administrada por un Consejo de Administración, compuesto por tres miembros como mínimo y siete como máxi...
Revocaciones — 16/03/2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEINADO MORENO LUIS;BAZAGA GONZALEZ FRANCISCO. Apo.Manc.: CALVO MOREIRA JESUS;IMAZ RUBALCABA JAVIER. Nombramientos. Apo.Sol.: BAZAGA GONZALEZ FRANCISCO. Apo.Manc.: BAZAGA GONZALEZ FRANCISCO;C...
Revocaciones — 12/01/2009
Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3459, L 3459, F 31, S 8, H PO 32640, I/A 14º (23.12.08).