Actos destacados
Articulo 378 — 15/10/2019
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2018 mediante certificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 3429, L 3429, F 27, S 8, H PO...
Nombramientos — 27/12/2018
Nombramientos. Apoderado: CORADA PEREZ MARIA SONIA. Datos registrales. T 3429, L 3429, F 27, S 8, H PO 45230, I/A 14 (17.12.18).
Revocaciones — 06/08/2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GRANDAL BOUZA JAVIER. Datos registrales. T 3429, L 3429, F 27, S 8, H PO 45230, I/A 13 (30.07.18).
Ceses/dimisiones — 12/06/2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SEGUIN SANCHEZ FRANCISCO JAVIER;BOTAS RATERA IGNACIO. Nombramientos. Consejero: BOTAS RATERA IGNACIO;SEGUIN SANCHEZ FRANCISCO JAVIER;NUÑEZ ABELENDA PEDRO. Presidente: BOTAS RATERA IGNACIO....
Ceses/dimisiones — 12/06/2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: SEGUIN SANCHEZ FRANCISCO JAVIER;NUÑEZ ABELENDA PEDRO;BOTAS RATERA IGNACIO. Secretario: NUÑEZ ABELENDA PEDRO. Presidente: BOTAS RATERA IGNACIO. Nombramientos. Adm. Unico: BOTAS RATERA IGNACIO...
Nombramientos — 29/12/2017
Nombramientos. Apo.Sol.: MACIÑEIRAS FERNANDEZ OSCAR;MACIÑEIRAS FERNANDEZ OSCAR;GONZALEZ-BABE IGLESIAS RAMON;KRISTO GABRIELLA;SAAVEDRA OBERMANN FERNANDO. Apo.Man.Soli: MACIÑEIRAS FERNANDEZ OSCAR. Apo.Manc.: GONZALEZ-BABE...
Nombramientos — 08/02/2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MACIÑEIRAS FERNANDEZ OSCAR;GONZALEZ-BABE IGLESIAS RAMON;KRISTO GABRIELLA;GRANDAL BOUZA JAVIER. Datos registrales. T 3429, L 3429, F 24, S 8, H PO 45230, I/A 8 (28.01.16).
Cambio de domicilio social — 08/02/2016
Cambio de domicilio social. C/ VELAZQUEZ MORENO 29 3 (VIGO). Datos registrales. T 3429, L 3429, F 25, S 8, H PO 45230, I/A 9 (28.01.16).
Ampliacion del objeto social — 30/12/2015
Ampliacion del objeto social. d) Las actividades de construcción de obras consistentes en la fabricación e instalación de fachadas en vidrio y ventanas, incluyendo el suministro o enajenación de los bienes y la prestaci...
Ampliación de capital — 09/05/2014
Ampliación de capital. Capital: 1.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 22.500,00 Euros. Datos registrales. T 3429, L 3429, F 23, S 8, H PO 45230, I/A 6 (28.04.14).
Nombramientos — 13/02/2014
Nombramientos. Apo.Manc.: RICO GONZALEZ MARIA ISABEL;MACIÑEIRAS FERNANDEZ OSCAR;GONZALEZ-BABE IGLESIAS RAMON. Datos registrales. T 3429, L 3429, F 23, S 8, H PO 45230, I/A 5 ( 4.02.14).
Ampliación de capital — 04/02/2014
Ampliación de capital. Capital: 3.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 21.000,00 Euros. Datos registrales. T 3429, L 3429, F 23, S 8, H PO 45230, I/A 4 (24.01.14).
Nombramientos — 03/09/2013
Nombramientos. Apoderado: RICO GONZALEZ MARIA ISABEL. Datos registrales. T 3429, L 3429, F 22, S 8, H PO 45230, I/A 3 (26.08.13).
Nombramientos — 09/12/2010
Nombramientos. Apoderado: MACIÑEIRAS FERNANDEZ OSCAR. Datos registrales. T 3429, L 3429, F 22, S 8, H PO 45230, I/A 2 (23.11.10). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 234 Jueves 9 de diciembre de 2010 Pág. 67924...