Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 11 tarjetas
13/12/2018 Sec. I Nombramientos Jaén
Jaén-499071

Nombramientos — 13/12/2018

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 439 , F 11, S 8, H J 7362, I/A 46 ( 7.12.18).

25/05/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Jaén
Jaén-217263

Ceses/dimisiones — 25/05/2017

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ACEK DESARROLLO Y GESTION INDUSTRIAL SOCIEDAD LIMI. Nombramientos. Adm. Unico: GESTAMP AUTOMOCION S.A. Datos registrales. T 439 , F 11, S 8, H J 7362, I/A 44 (18.05.17). BOLETÍN OFICIAL DEL...

14/02/2017 Sec. I Nombramientos Jaén
Jaén-71984

Nombramientos — 14/02/2017

Nombramientos. Apoderado: DE LA FLOR RIBERAS MANUEL. Datos registrales. T 439 , F 11, S 8, H J 7362, I/A 43 ( 7.02.17).

22/01/2016 Sec. I Reelecciones Jaén
Jaén-27216

Reelecciones — 22/01/2016

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 439 , F 11, S 8, H J 7362, I/A 41 (15.01.16).

14/07/2015 Sec. I Otros conceptos: CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL DEL ADMINISTRADOR UNICO, QUE PASA A DENOMINARSE "ACEK DESARROLLO Y GESTION INDUSTRIAL SL", egún escritura otorgada en Madrid el 5/2/2015, ante el notario don Miguel Angel Rodríguez García,protocolo 301,inscrita en el RM MADRID al tomo 25799,folio 218, Ins Jaén
Jaén-287792

Otros conceptos: cambio de denominacion social del administrador unico, que pasa a denominarse "acek desarrollo y gestion industrial sl", egún escritura otorgada en madrid el 5/2/2015, ante el notario don miguel angel rodríguez garcía,protocolo 301,inscrita en el rm madrid al tomo 25799,folio 218, ins — 14/07/2015

Otros conceptos: CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL DEL ADMINISTRADOR UNICO, QUE PASA A DENOMINARSE "ACEK DESARROLLO Y GESTION INDUSTRIAL SL", egún escritura otorgada en Madrid el 5/2/2015, ante el notario don Miguel Angel R...

29/07/2013 Sec. I Reelecciones Jaén
Jaén-338165

Reelecciones — 29/07/2013

Reelecciones. Adm. Unico: CORPORACION GESTAMP SL. Datos registrales. T 439 , F 9, S 8, H J 7362, I/A 36 (22.07.13).

25/06/2013 Sec. I Nombramientos Jaén
Jaén-289070

Nombramientos — 25/06/2013

Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ PASCUAL DAVID. Datos registrales. T 439 , F 9, S 8, H J 7362, I/A 35 (18.06.13).

20/11/2012 Sec. I Reelecciones Jaén
Jaén-473993

Reelecciones — 20/11/2012

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 439 , F 9, S 8, H J 7362, I/A 34 (12.11.12).

05/02/2010 Sec. I Reelecciones Jaén
Jaén-48808

Reelecciones — 05/02/2010

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 439 , F 8, S 8, H J 7362, I/A 30 (27.01.10).

02/06/2009 Sec. I Reelecciones Jaén
Jaén-250615

Reelecciones — 02/06/2009

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 439 , F 7, S 8, H J 7362, I/A 27 (25.05.09). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

05/05/2009 Sec. I Revocaciones Jaén
Jaén-207999

Revocaciones — 05/05/2009

Revocaciones. Apoderado: GARCIA MORILLAS JUAN CARLOS. Nombramientos. Apoderado: GARCIA MORILLAS JUAN CARLOS. Datos registrales. T 439 , F 7, S 8, H J 7362, I/A 26 (23.04.09). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGIST...