Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 5 tarjetas
27/08/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-351527

Ceses/dimisiones — 27/08/2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: WILKINSON BRIAN;DYER ANTHONY STEPHEN. Presidente: WILKINSON BRIAN. Secretario: DYER ANTHONY STEPHEN. Nombramientos. Consejero: DOS SANTOS FERREIRA RUI JORGE;FARZAD SALAR;LEWIS KEITH JOHN. Pr...

27/08/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-351528

Revocaciones — 27/08/2018

Revocaciones. Apoderado: DYER ANTHONY STEPHEN. Apo.Man.Soli: WILKINSON BRIAN;JACKMAN ANDREW;BRANSON CASPAR BEN;DOS SANTOS FERREIRA RUI JORGE;FARZAD SALAR;VILLOLDO MAZO CARLOS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: JACKMAN ANDREW...

27/08/2018 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-351529

Cambio de domicilio social — 27/08/2018

Cambio de domicilio social. C/ EDGAR NEVILLE 6, ESPACIO OFFICE MADRID (MADRID). Datos registrales. T 35859 , F 199, S 8, H M 644296, I/A 6 (17.08.18).

19/05/2017 Sec. I Constitución Madrid
Madrid-207254

Constitución — 19/05/2017

Constitución. Comienzo de operaciones: 28.04.17. Objeto social: La Sociedad tendrá por objeto la realización directa, indirectamente o por medios telemáticos tales como internet, en España o en el extranjero, de la cont...

19/05/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-207255

Nombramientos — 19/05/2017

Nombramientos. Apoderado: DYER ANTHONY STEPHEN. Datos registrales. T 35859 , F 195, S 8, H M 644296, I/A 2 ( 9.05.17).