Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 10 tarjetas
29/10/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-431166

Revocaciones — 29/10/2018

Revocaciones. Apoderado: GALLEGO LOPEZ ARACELI. Apo.Man.Soli: VACAS GOMEZ ANTONIO. Datos registrales. T 35601 , F 187, S 8, H M 12507, I/A 97 (19.10.18).

29/10/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-431167

Nombramientos — 29/10/2018

Nombramientos. Apoderado: NIETO MORENO RUBEN. Datos registrales. T 35601 , F 187, S 8, H M 12507, I/A 98 (19.10.18).

29/10/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-431168

Nombramientos — 29/10/2018

Nombramientos. Apo.Man.Soli: NIETO MORENO RUBEN. Datos registrales. T 35601 , F 188, S 8, H M 12507, I/A 99 (19.10.18).

25/10/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-426196

Nombramientos — 25/10/2018

Nombramientos. Con.Delegado: AGUIRRE FERNANDEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 35601 , F 187, S 8, H M 12507, I/A 96 (17.10.18).

02/08/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-318005

Ceses/dimisiones — 02/08/2017

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GALLEGO LOPEZ ARACELI. Nombramientos. SecreNoConsj: PALAZON QUEVEDO ESTEBAN. Datos registrales. T 35601 , F 186, S 8, H M 12507, I/A 94 (26.07.17).

05/04/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-153151

Ceses/dimisiones — 05/04/2017

Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ ZAMALLOA BARAIBAR GONZALO. Con.Delegado: GOMEZ ZAMALLOA BARAIBAR GONZALO. Presidente: GOMEZ ZAMALLOA BARAIBAR GONZALO. Nombramientos. Consejero: AGUIRRE FERNANDEZ JOSE MARIA. Con.Deleg...

29/07/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-310841

Ceses/dimisiones — 29/07/2014

Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ MUÑOZ MANUEL. Nombramientos. Consejero: ALVAREZ-CEDRON HERNANDEZ ANTONIO. Reelecciones. Consejero: MARTIN ABELLA MANUEL. Con.Delegado: GOMEZ ZAMALLOA BARAIBAR GONZALO. Presidente: GO...

12/08/2011 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-337156

Cambio de domicilio social — 12/08/2011

Cambio de domicilio social. C/ ORENSE 6 (MADRID). Datos registrales. T 13837 , F 112, S 8, H M 12507, I/A 89 ( 2.08.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 154 Viernes 12 de agosto de 2011 Pág. 41518 cve: BORME...

01/07/2011 Sec. I Otros conceptos: SUSTITUIDAS LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL PARRAFO 2 Madrid
Madrid-279010

Otros conceptos: sustituidas las facultades seÑaladas en el parrafo 2 — 01/07/2011

Otros conceptos: SUSTITUIDAS LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL PARRAFO 2.1 A FAVOR DE DON JAVIER MEDINA REUS CONFERIDAS EN ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 84& DE LA HOJA SOCIAL.- Datos registrales. T 13837 , F 111, S 8,...

01/07/2011 Sec. I Otros conceptos: SUSTITUIDAS LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL PARRAFO 2 Madrid
Madrid-279011

Otros conceptos: sustituidas las facultades seÑaladas en el parrafo 2 — 01/07/2011

Otros conceptos: SUSTITUIDAS LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL PARRAFO 2.1 A FAVOR DE DON PABLO ROSADO RODRIGUEZ CONFERIDAS EN ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 76& DE LA HOJA SOCIAL. Datos registrales. T 13837 , F 111, S...