Actos destacados
Modificaciones estatutarias — 17/01/2018
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: ARTICULO 1º.- La Sociedad se denomina "Nedgia Galicia, S.A.". Cambio de denominación social. NEDGIA GALICIA SA. Datos registrales. T 270 , F 160, S 8, H SC 6171, I...
Nombramientos — 27/11/2017
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 270 , F 160, S 8, H SC 6171, I/A 280 (20.11.17). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Nombramientos — 14/11/2017
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ LODEIROS SUSANA. Datos registrales. T 270 , F 155, S 8, H SC 6171, I/A 274 ( 3.11.17).
Nombramientos — 14/11/2017
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ALVAREZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 270 , F 156, S 8, H SC 6171, I/A 275 ( 3.11.17).
Nombramientos — 14/11/2017
Nombramientos. Apoderado: SERRATE PIETX CRISTINA;GRIS SANCHEZ RAQUEL. Datos registrales. T 270 , F 156, S 8, H SC 6171, I/A 276 ( 3.11.17).
Nombramientos — 14/11/2017
Nombramientos. Apo.Sol.: CIRUGEDA GARCIA MANUEL;MARTIN JIMENEZ ALEJANDRO;MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO;MARTINEZ DIAZ ANGEL JAVIER. Datos registrales. T 270 , F 158, S 8, H SC 6171, I/A 277 ( 3.11.17).
Nombramientos — 14/11/2017
Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ FEBREL BALTASAR;PARRA ROMERO INMACULADA. Datos registrales. T 270 , F 158, S 8, H SC 6171, I/A 278 ( 3.11.17).
Revocaciones — 14/11/2017
Revocaciones. Apoderado: SANTALO LLUCH JOSEP;SANTALO LLUCH JOSEP;DOMENECH SABATER FRANCESC. Apo.Sol.: SANTALO LLUCH JOSEP. Apoderado: MENENDEZ FERNANDEZ RUBEN. Datos registrales. T 270 , F 159, S 8, H SC 6171, I/A 279 (...
Reelecciones — 13/10/2017
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 270 , F 155, S 8, H SC 6171, I/A 273 ( 3.10.17).
Ceses/dimisiones — 24/08/2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ PELLICER MANUEL. Nombramientos. Consejero: GUTIERREZ URBON MARIA TERESA. Datos registrales. T 270 , F 154, S 8, H SC 6171, I/A 271 (14.08.17).
Revocaciones — 24/08/2017
Revocaciones. Apo.Sol.: ZUGASTI GILA MIGUEL ANGEL. Apoderado: ZUGASTI GILA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 270 , F 154, S 8, H SC 6171, I/A 272 (14.08.17).
Ceses/dimisiones — 07/06/2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: ABANCA CORPORACION INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL SL. Datos registrales. T 270 , F 152, S 8, H SC 6171, I/A 266 (30.05.17).
Ceses/dimisiones — 07/06/2017
Ceses/Dimisiones. Secretario: ARENAS PEREZ PILAR. Nombramientos. Secretario: QUINTANA OLMO MINERVA. Datos registrales. T 270 , F 152, S 8, H SC 6171, I/A 267 (30.05.17).
Nombramientos — 07/06/2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESTAJO MARTI MANUEL. Datos registrales. T 270 , F 153, S 8, H SC 6171, I/A 268 (30.05.17).
Nombramientos — 07/06/2017
Nombramientos. Apoderado: MARTIN DOMINGUEZ NURIA. Datos registrales. T 270 , F 153, S 8, H SC 6171, I/A 269 (30.05.17).
Revocaciones — 07/06/2017
Revocaciones. Apoderado: ARENAS PEREZ PILAR. Apo.Sol.: PEREZ ALARCON JOSE LUIS. Datos registrales. T 270 , F 154, S 8, H SC 6171, I/A 270 (30.05.17).
Nombramientos — 06/03/2017
Nombramientos. Apoderado: PAZOS ARRANZ JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 270 , F 151, S 8, H SC 6171, I/A 264 (23.02.17).
Ampliación de capital — 06/03/2017
Ampliación de capital. Suscrito: 437.880,00 Euros. Desembolsado: 437.880,00 Euros. Resultante Suscrito: 34.006.440,00 Euros. Resultante Desembolsado: 34.006.440,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los est...
Ceses/dimisiones — 03/03/2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMARA GARCIA ROBERTO;HUARTE LAZARO RAFAEL;GAS NATURAL CATALUNYA SDG SA;GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA. Presidente: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA;GAS NATURAL CATALUNYA SDG SA. Revocacione...
Reelecciones — 30/11/2016
Reelecciones. Consejero: ABANCA CORPORACION INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL SL. Datos registrales. T 270 , F 146, S 8, H SC 6171, I/A 259 (17.11.16).
Reelecciones — 30/11/2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 270 , F 146, S 8, H SC 6171, I/A 260 (17.11.16).
Ampliación de capital — 30/11/2016
Ampliación de capital. Suscrito: 714.420,00 Euros. Desembolsado: 714.420,00 Euros. Resultante Suscrito: 33.568.560,00 Euros. Resultante Desembolsado: 33.568.560,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los est...
Ceses/dimisiones — 29/08/2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: MEMBRILLO BONILLA ANDRES;VARELA GOMEZ XIAO. Nombramientos. Consejero: SUAREZ ALVAREZ RAUL;MERA RICO EDUARDO. Datos registrales. T 270 , F 138, S 8, H SC 6171, I/A 247 (19.08.16).
Modificaciones estatutarias — 29/08/2016
Modificaciones estatutarias. Artículo 2 BIS.- Representación de otras personas jurídicas. La Sociedad podrá actuar en representación de otras personas jurídicas ante las Administraciones Públicas. Asimismo, y sin perjui...