Actos destacados
Modificaciones estatutarias — 30/10/2012
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 1. Denominación.-. Cambio de denominación social. GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SL. Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: GAM ESTE ALQUILER DE MAQUINAR...
Reelecciones — 21/08/2012
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3642 , F 84, S 8, H AS 7633, I/A 49 ( 7.08.12).
Revocaciones — 24/02/2012
Revocaciones. Apo.Sol.: TRELLES SUAREZ ANTONIO. Apo.Manc.: TRELLES SUAREZ ANTONIO. Apo.Sol.: BERMUDEZ SANCHEZ MARIA ELSA. Apo.Manc.: BERMUDEZ SANCHEZ MARIA ELSA. Apoderado: MUÑOZ BARAGAÑO ORENCIO. Apo.Manc.: MALNERO DIA...
Nombramientos — 10/02/2012
Nombramientos. Apoderado: MALNERO DIAZ MERCEDES. Datos registrales. T 3642 , F 83, S 8, H AS 7633, I/A 46 (31.01.12).
Revocaciones — 10/02/2012
Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ ARAOZ GOMEZ-ACEBO CARLOS. Datos registrales. T 3642 , F 83, S 8, H AS 7633, I/A 47 (31.01.12).
Nombramientos — 25/01/2012
Nombramientos. Apoderado: URBIETA ARIAS IGNACIO. Datos registrales. T 3642 , F 81, S 8, H AS 7633, I/A 43 (13.01.12).
Nombramientos — 25/01/2012
Nombramientos. Apoderado: BULNES BULNES JOSE FAUSTINO. Datos registrales. T 3642 , F 82, S 8, H AS 7633, I/A 44 (13.01.12).
Nombramientos — 25/01/2012
Nombramientos. Apoderado: NARANJO LIMON ROSA MARIA. Datos registrales. T 3642 , F 82, S 8, H AS 7633, I/A 45 (13.01.12).
Ampliación de capital — 21/12/2011
Ampliación de capital. Capital: 27.000.045,20 Euros. Resultante Suscrito: 27.140.378,70 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 3642 , F 69, S 8, H AS 7633, I/A...
Nombramientos — 22/11/2011
Nombramientos. Apoderado: COBO ARAGONESES JOSE LUIS. Datos registrales. T 3642 , F 69, S 8, H AS 7633, I/A 41 (11.11.11).
Nombramientos — 05/08/2011
Nombramientos. Apo.Sol.: AGUADO ESTEVEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3642 , F 68, S 8, H AS 7633, I/A 40 (25.07.11).
Reelecciones — 02/11/2010
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3642 , F 68, S 8, H AS 7633, I/A 38 (20.10.10).
Revocaciones — 21/10/2010
Revocaciones. Apo.Sol.: MAYO PRIETO ALBERTO. Datos registrales. T 3642 , F 68, S 8, H AS 7633, I/A 37 ( 8.10.10).
Nombramientos — 19/10/2010
Nombramientos. Apo.Sol.: NARANJO LIMON ROSA MARIA;FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3642 , F 68, S 8, H AS 7633, I/A 36 ( 6.10.10).
Revocaciones — 24/09/2010
Revocaciones. Apo.Sol.: DIAZ ARGUELLES JUSTO. Apo.Manc.: DIAZ ARGUELLES JUSTO. Datos registrales. T 3642 , F 67, S 8, H AS 7633, I/A 34 (13.09.10).
Nombramientos — 24/09/2010
Nombramientos. Apo.Sol.: AGUADO ESTEVEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3642 , F 67, S 8, H AS 7633, I/A 35 (13.09.10).
Reelecciones — 19/05/2010
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3642 , F 67, S 8, H AS 7633, I/A 33 ( 7.05.10).
Nombramientos — 29/06/2009
Nombramientos. Apo.Sol.: CAMPILLO FERNANDEZ JOSE PABLO. Apo.Manc.: CAMPILLO FERNANDEZ JOSE PABLO;RODRIGUEZ FERNANDEZ ALVARO;FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID. Datos registrales. T 3642 , F 66, S 8, H AS 7633, I/A 31 (15.06.09).
Nombramientos — 03/04/2009
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ ARAOZ GOMEZ-ACEBO CARLOS. Datos registrales. T 3642 , F 64, S 8, H AS 7633, I/A 28 (24.03.09).
Nombramientos — 03/04/2009
Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANDEZ RUIGOMEZ MARIO. Datos registrales. T 3642 , F 65, S 8, H AS 7633, I/A 29 (24.03.09).
Nombramientos — 03/04/2009
Nombramientos. Apo.Sol.: MAYO PRIETO ALBERTO. Datos registrales. T 3642 , F 66, S 8, H AS 7633, I/A 30 (24.03.09).
Nombramientos — 04/03/2009
Nombramientos. Apoderado: BURGER DAVID. Datos registrales. T 3642 , F 64, S 8, H AS 7633, I/A 27 (19.02.09).
Fusión por absorción — 21/01/2009
Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: GAM CASTILLA Y LEON SL. Datos registrales. T 3642 , F 63, S 8, H AS 7633, I/A 26 ( 5.01.09).