Actos destacados
Otros conceptos: cerrada la hoja por plazo provisional de seis meses, conforme al artículo 231 rrm — 18/08/2010
Otros conceptos: Cerrada la hoja por plazo provisional de seis meses, conforme al artículo 231 RRM. Datos registrales. T 3689 , F 20, S 8, H Z 2760, I/A 58 F ( 9.08.10).
Nombramientos — 19/02/2010
Nombramientos. Apoderado: VILLEGAS RODRIGUEZ ALICIA. Datos registrales. T 3689 , F 20, S 8, H Z 2760, I/A 58 (10.02.10).
Nombramientos — 02/10/2009
Nombramientos. Apoderado: INIGO JIMENEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 3689 , F 19, S 8, H Z 2760, I/A 57 (23.09.09).
Sociedad unipersonal — 22/07/2009
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ MILIAN JOSE LUIS;CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON. Presidente: C...
Nombramientos — 22/07/2009
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LA FUENTE MARTINEZ GERARDO;FERREÑO SANCHEZ JOSE-MANUEL;PARDO CASTRO JOSE FERNANDO. Datos registrales. T 3689 , F 17, S 8, H Z 2760, I/A 55 (13.07.09).
Ampliación de capital — 03/06/2009
Ampliación de capital. Suscrito: 16.999.987,86 Euros. Desembolsado: 16.999.987,86 Euros. Resultante Suscrito: 41.296.923,72 Euros. Resultante Desembolsado: 41.296.923,72 Euros. Datos registrales. T 3689 , F 16, S 8, H Z...
Ampliación de capital — 03/06/2009
Ampliación de capital. Suscrito: 16.814.755,93 Euros. Desembolsado: 16.814.755,93 Euros. Resultante Suscrito: 58.111.679,65 Euros. Resultante Desembolsado: 58.111.679,65 Euros. Datos registrales. T 3689 , F 16, S 8, H Z...
Declaración de unipersonalidad — 03/06/2009
Declaración de unipersonalidad. Socio único: CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON. Datos registrales. T 3689 , F 16, S 8, H Z 2760, I/A 53 (25.05.09).
Nombramientos — 27/04/2009
Nombramientos. Vicepresid.: CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DESARROLLO EMPRES. Datos registrales. T 3689 , F 16, S 8, H Z 2760, I/A 50 (16.04.09).
Ceses/dimisiones — 18/03/2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: LALAGUNA ARANDA JOSE AGUSTIN. Vicepresid.: TRUEBA CORTES JOSE MARIA. Consejero: TRUEBA CORTES JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DESARROLLO EMPRES. Datos...
Revocaciones — 11/03/2009
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PONTAQUE PONTAQUE JESUS. Apoderado: LOSTAO ARGILES SANTIAGO-JOSE. Apo.Man.Soli: BERNAD POLO FERNANDO. Datos registrales. T 3689 , F 15, S 8, H Z 2760, I/A 47 ( 2.03.09).
Nombramientos — 11/03/2009
Nombramientos. Apo.Sol.: TRUEBA CORTES JOSE MARIA;CANO SANCHEZ LORENZO. Datos registrales. T 3689 , F 15, S 8, H Z 2760, I/A 48 ( 2.03.09).
Nombramientos — 16/02/2009
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3356 , F 225, S 8, H Z 2760, I/A 45 ( 5.02.09).
Nombramientos — 16/02/2009
Nombramientos. Apo.Sol.: BERNAD POLO FERNANDO. Apo.Man.Soli: BERNAD POLO FERNANDO;PONTAQUE PONTAQUE JESUS. Apo.Manc.: CANO SANCHEZ LORENZO;TRUEBA CORTES JOSE MARIA;GRACIA CONEJOS MARIA ROSA;LALAGUNA ARANDA JOSE AGUSTIN....
Nombramientos — 12/02/2009
Nombramientos. Consejero: TRUEBA CORTES JOSE MARIA;GRACIA CONEJOS MARIA ROSA;CANO SANCHEZ LORENZO. Datos registrales. T 3356 , F 224, S 8, H Z 2760, I/A 42 ( 2.02.09).
Ceses/dimisiones — 12/02/2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPO TORRIJOS ANTONIO TOMAS;BURILLO ELHOMBRE JOSE MARIA. Vicepresid.: LALAGUNA ARANDA JOSE AGUSTIN. Nombramientos. Vicepresid.: TRUEBA CORTES JOSE MARIA. Apo.Manc.: TRUEBA CORTES JOSE MARIA...
Ceses/dimisiones — 12/02/2009
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GARAY GOMEZ ENRIQUE. Consejero: GARAY GOMEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 3356 , F 225, S 8, H Z 2760, I/A 44 ( 2.02.09).
Ampliación de capital — 10/02/2009
Ampliación de capital. Suscrito: 1.682.833,88 Euros. Desembolsado: 1.682.833,88 Euros. Resultante Suscrito: 24.296.935,86 Euros. Resultante Desembolsado: 24.296.935,86 Euros. Datos registrales. T 3356 , F 224, S 8, H Z...