Actos destacados
Nombramientos — 23/09/2016
Nombramientos. Apoderado: BARRAU PUY IGNACIO. Datos registrales. T 5006, L 3913, F 75, S 8, H MA 19109, I/A 20 (14.09.16).
Revocaciones — 23/06/2014
Revocaciones. Apo.Manc.: CERVAN JIMENEZ FRANCISCO JESUS. Datos registrales. T 5006, L 3913, F 75, S 8, H MA 19109, I/A 19 (11.06.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 116 Lunes 23 de junio de 2014 Pág. 28123...
Revocaciones — 30/04/2013
Revocaciones. Apo.Sol.: O'CONNOR DESMOND;MCCABE PAUL HUGH. Apo.Manc.: MCCABE PAUL HUGH. Datos registrales. T 5006, L 3913, F 75, S 8, H MA 19109, I/A 18 (19.04.13).
Nombramientos — 11/05/2012
Nombramientos. Apoderado: BUESA AZNAR EMERITO. Datos registrales. T 4039, L 2950, F 156, S 8, H MA 19109, I/A 16 (25.04.12).
Revocaciones — 03/11/2011
Revocaciones. Apoderado: ROMERO VALLEJO JOSE LUIS. Apo.Manc.: ROMERO VALLEJO JOSE LUIS. Datos registrales. T 4039, L 2950, F 156, S 8, H MA 19109, I/A 15 (17.10.11).