Actos destacados
Nombramientos — 03/07/2019
Nombramientos. Apoderado: MADOZ BELAUNZARAN XABIER. Datos registrales. T 1522 , F 31, S 8, H NA 507, I/A 56 (25.06.19).
Revocaciones — 20/02/2019
Revocaciones. Apoderado: PLAZA HERRERO YOLANDA;PLAZA HERREROS YOLANDA. Datos registrales. T 1522 , F 31, S 8, H NA 507, I/A 55 (12.02.19).
Reelecciones — 21/01/2019
Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS LP SL. Datos registrales. T 1522 , F 31, S 8, H NA 507, I/A 54 (10.01.19).
Nombramientos — 05/02/2018
Nombramientos. Apoderado: PEREZ TRULLOS JUAN JOSE. Datos registrales. T 1522 , F 30, S 8, H NA 507, I/A 53 (25.01.18). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 25 Lunes 5 de febrero de 2018 Pág. 6017 cve: BORME-A-201...
Nombramientos — 19/10/2017
Nombramientos. Aud.C.Con.: MOORE STEPHENS LP SL. Datos registrales. T 1522 , F 30, S 8, H NA 507, I/A 52 (10.10.17).
Modificaciones estatutarias — 16/10/2017
Modificaciones estatutarias. Modificación del artículo 7º de los Estatutos, relativo al capital social, como consecuencia del cambio de clase de acciones.. Otros conceptos: Cambiada a la "Serie A" las acciones números 3...
Situación concursal — 26/04/2017
Situación concursal. Procedimiento concursal 533/2012. FIRME: Si, Fecha de resolución 17/02/2017. Sentencia de aprobación del convenio. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PAMPLONA. Juez: Dª VICTORIA RUBIO JIMENE...
Ceses/dimisiones — 29/02/2016
Ceses/Dimisiones. Auditor: REDIN LECEAGA JON ANDER. Aud.Supl.: GOMEZ MARTINEZ FELIPE. Nombramientos. Auditor: MOORE STEPHENS LP SL. Datos registrales. T 1522 , F 29, S 8, H NA 507, I/A 49 ( 8.02.16).
Ceses/dimisiones — 29/04/2015
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MADOZ ANSORENA BAUTISTA ALBERTO. Nombramientos. Con.Delegado: MADOZ ANSORENA BAUTISTA ALBERTO. Reelecciones. Presidente: MADOZ ANSORENA BAUTISTA ALBERTO. Vicepresid.: CESTAU URQUIOLA MIGU...
Cancelaciones de oficio de nombramientos — 05/02/2015
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Aud.Supl.: GOMEZ MARTINEZ FELIPE. Revocaciones. Auditor: SEGURA LOPEZ LADISLAO. Nombramientos. Auditor: REDIN LECEAGA JON ANDER. Aud.Supl.: GOMEZ MARTINEZ FELIPE. Datos registra...
Revocaciones — 05/02/2015
Revocaciones. Apoderado: PLAZA HERREROS YOLANDA. Datos registrales. T 1522 , F 28, S 8, H NA 507, I/A 46 (15.01.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 24 Jueves 5 de febrero de 2015 Pág. 5456 cve: BORME-A-2015...
Nombramientos — 05/02/2015
Nombramientos. Apoderado: PASCUAL PEREZ OLGA. Datos registrales. T 1522 , F 28, S 8, H NA 507, I/A 47 (15.01.15).
Ceses/dimisiones — 17/01/2014
Ceses/Dimisiones. Auditor: LOPEZ REMIRO JOSE LUIS. Nombramientos. Auditor: SEGURA LOPEZ LADISLAO. Datos registrales. T 1522 , F 27, S 8, H NA 507, I/A 43 ( 9.01.14).
Situación concursal — 04/11/2013
Situación concursal. Procedimiento concursal 533/2012. FIRME: Si, Fecha de resolución 18/07/2013. Auto de apertura de la fase de convenio. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PAMPLONA. Juez: D& ESTHER FERNANDEZ A...
Nombramientos — 16/01/2012
Nombramientos. Aud.Supl.: GOMEZ MARTINEZ FELIPE. Reelecciones. Auditor: LOPEZ REMIRO JOSE LUIS. Datos registrales. T 1522 , F 25, S 8, H NA 507, I/A 38 ( 3.01.12).
Nombramientos — 16/01/2012
Nombramientos. Aud.Supl.C.C: GOMEZ MARTINEZ FELIPE. Reelecciones. Aud.C.Con.: LOPEZ REMIRO JOSE LUIS. Datos registrales. T 1522 , F 25, S 8, H NA 507, I/A 39 ( 3.01.12).
Reelecciones — 03/02/2011
Reelecciones. Aud.Supl.: FLAMARIQUE IBAÑEZ JAVIER. Datos registrales. T 1522 , F 25, S 8, H NA 507, I/A 37 (19.01.11).
Nombramientos — 11/08/2010
Nombramientos. Apoderado: ROSAS GOIZ ROSENDO. Datos registrales. T 1522 , F 24, S 8, H NA000507, I/A00036 ( 2.08.10).
Nombramientos — 29/07/2010
Nombramientos. Rpte. Suc.: MIRANDA FERNANDEZ ALBERTO FERNANDO;MARINA PATIÑO MONTSERRAT. Otros conceptos: APERTURA SUCURSAL. Denominación: FLUITECNIK SOCIEDAD ANONIMA, SUCURSAL EN MEXICO. Domicilio social: 16 PONIENTE 10...
Ceses/dimisiones — 29/07/2010
Ceses/Dimisiones. Rpte. Suc.: MIRANDA FERNANDEZ ALBERTO FERNANDO;MARINA PATIÑO MONTSERRAT. Nombramientos. Rpte. Suc.: MADOZ ANSORENA BAUTISTA ALBERTO. Datos registrales. T 1522 , F 23, S 8, H NA000507, I/A00035 (16.07.1...
Ceses/dimisiones — 30/03/2010
Ceses/Dimisiones. Vicepresiden: CESTAU URQUIOLA MIGUEL JOSE. Presidente: MADOZ ANSORENA BAUTISTA ALBERTO. Secretario: MADOZ ANSORENA MANUEL. Cons.Delegad: MADOZ ANSORENA BAUTISTA ALBERTO. Nombramientos. Consejero: MADOZ...
Otros conceptos: fusion — 08/01/2010
Otros conceptos: FUSION. Con fecha 26/06/2009. FUSIONAR la Sociedad =FLUITECNIK, S.A.ó con =DIPLOSISTEMAS, S.A.ó, mediante la ABSORCION de la última sociedad por la primera, con disolución sin liquidación de la absorbid...
Reelecciones — 27/01/2009
Reelecciones. Auditor Titu: LOPEZ REMIRO JOSE LUIS. Datos registrales. T 31 , F 93, S 8, H NA000507, I/A00028 (14.01.09).
Nombramientos — 27/01/2009
Nombramientos. Aud.Tit.Grup: LOPEZ REMIRO JOSE LUIS. Aud.Sup.Grup: FLAMARIQUE IBAÑEZ JAVIER. Datos registrales. T 31 , F 93, S 8, H NA000507, I/A00029 (14.01.09).