Actos destacados
Nombramientos — 08/08/2019
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 163 , F 213, S 8, H IF 3977, I/A 46 (26.07.19).
Ceses/dimisiones — 08/08/2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ROBLES COLLADO DIEGO. Nombramientos. Adm. Unico: ATLANTIC-MEDITERRANEAN HOTELS & RESORTS SOCIEDAD L. Datos registrales. T 163 , F 213, S 8, H IF 3977, I/A 47 (26.07.19). BOLETÍN OFICIAL DEL...
Nombramientos — 31/03/2017
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 163 , F 213, S 8, H IF 3977, I/A 45 (15.03.17).
Reducción de capital — 14/12/2015
Reducción de capital. Importe reducción: 23.945.627,32 Euros. Resultante Suscrito: 5.000.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 163 , F 213, S 8, H IF 39...
Ceses/dimisiones — 12/06/2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: FELIP COTTER GABRIEL. Nombramientos. Consejero: MURILLO TENA MANUEL. Datos registrales. T 152 , F 1, S 8, H IF 3977, I/A 36 ( 7.12.11).
Nombramientos — 09/12/2013
Nombramientos. Apoderado: FARRAG AHMED;GOMEZ CABRERA MIGUEL ANGEL;GALVAN GARCIA LUZ DEL PINO. Datos registrales. T 152 , F 1, S 8, H IF 3977, I/A 37 ( 7.05.12).
Revocaciones — 09/12/2013
Revocaciones. Apoderado: FARRAG AHMED;FARRAG AHMED;GOMEZ CABRERA MIGUEL ANGEL;GALVAN GARCIA LUZ DEL PINO;BARON LOPEZ IGNACIO;GALLARDO DONOSO FERNANDO. Datos registrales. T 152 , F 5, S 8, H IF 3977, I/A 41 (25.11.13).
Ceses/dimisiones — 15/11/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ GONZALEZ EUGENIA. Nombramientos. Consejero: DIAZ ALVAREZ SENEN IVAN. Datos registrales. T 152 , F 5, S 8, H IF 3977, I/A 40 (18.10.13).
Nombramientos — 14/02/2013
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 152 , F 5, S 8, H IF 3977, I/A 39 ( 5.02.13).
Ceses/dimisiones — 21/05/2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ MARTIN JOSE LUIS. Presidente: DE DIEGO DE GREGORIO GREGORIO. Consejero: GIRALDEZ QUIROGA JOAQUIN. Presidente: DE DIEGO DE GREGORIO GREGORIO. Cons.Del.Sol: DE DIEGO DE GREGORIO GREGO...
Revocaciones — 28/11/2011
Revocaciones. Apo.Manc.: FELIP COTTER GABRIEL NICOLAS;GARNICA ALVAREZ-ALONSO JUAN;GONZALEZ MARTIN JOSE LUIS;MURILLO TENA MANUEL;DE DIEGO DE GREGORIO GREGORIO;BAUTISTA VALERO DE BERNABE ALFONSO;GIRADLES QUIROGA JOAQUIN;D...
Ceses/dimisiones — 30/08/2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARNICA ALVAREZ-ALONSO JUAN;SOTELTUR SL;GARNICA ALVAREZ-ALONSO JUAN;SOTELTUR SL. Nombramientos. Consejero: PEREZ RODRIGUEZ JESUS;GONZALEZ MARTIN JOSE LUIS. Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL...
Revocaciones — 27/04/2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: VIÑOLY CONCEPCION JOSE. Apoderado: VIÑOLY CONCEPCION JOSE. Apo.Manc.: DE LA RUA GALAN JUAN ADOLFO;VIÑOLY CONCEPCION JOSE. Datos registrales. T 132 , F 158, S 8, H IF 3977, I/A 33 (12.04.11).
Revocaciones — 08/10/2010
Revocaciones. Apoderado: VILLARROYA ADELL MIGUEL. Datos registrales. T 132 , F 158, S 8, H IF 3977, I/A 32 (28.09.10).
Nombramientos — 02/07/2010
Nombramientos. Apo.Manc.: FELIP COTTER GABRIEL NICOLAS;GARNICA ALVAREZ-ALONSO JUAN;GONZALEZ MARTIN JOSE LUIS;MURILLO TENA MANUEL;DE LA RUA GALAN JUAN ADOLFO;DE DIEGO DE GREGORIO GREGORIO;BAUTISTA VALERO DE BERNABE ALFON...
Reducción de capital — 04/08/2009
Reducción de capital. Importe reducción: 4.368.366,66 Euros. Resultante Suscrito: 27.874.339,64 Euros. Ampliación de capital. Capital: 2.926.086,98 Euros. Resultante Suscrito: 30.800.426,62 Euros. Modificaciones estatut...
Reelecciones — 28/07/2009
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 132 , F 156, S 8, H IF 3977, I/A 27 ( 8.07.09).
Ceses/dimisiones — 02/03/2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: AZNAR ALBA AMBROSIO. Secretario: AZNAR ALBA AMBROSIO. Cons.Del.Sol: AZNAR ALBA AMBROSIO. Nombramientos. Consejero: DE DIEGO DE GREGORIO GREGORIO. Presidente: DE DIEGO DE GREGORIO GREGORIO. C...
Reelecciones — 08/01/2009
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 132 , F 155, S 8, H IF 3977, I/A 25 (17.12.08).