Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2011 17 tarjetas
23/03/2011 Sec. I Transformación de sociedad Madrid
Madrid-130680

Transformación de sociedad — 23/03/2011

Transformación de sociedad. Denominación y forma adoptada: FIDES CAPITAL SL. Nombramientos. Vicepresid.: VIÑAS TORMO EMILIO. Reelecciones. Consejero: VIÑAS TORMO EMILIO. Cons.Del.Sol: VIÑAS TORMO EMILIO. Presidente: SAN...

23/03/2011 Sec. I Transformación de sociedad Madrid
Madrid-130680

Transformación de sociedad — 23/03/2011

Transformación de sociedad. Denominación y forma adoptada: FIDES CAPITAL SL. Nombramientos. Vicepresid.: VIÑAS TORMO EMILIO. Reelecciones. Consejero: VIÑAS TORMO EMILIO. Cons.Del.Sol: VIÑAS TORMO EMILIO. Presidente: SAN...

23/02/2011 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-82814

Reelecciones — 23/02/2011

Reelecciones. Presidente: SANTANA APARICIO VICENTE. Consejero: PERENNIUS SL;SANTANA APARICIO VICENTE. Cons.Del.Sol: SANTANA APARICIO VICENTE. Datos registrales. T 22908 , F 90, S 8, H M 245290, I/A 38 (14.02.11).

23/02/2011 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-82814

Reelecciones — 23/02/2011

Reelecciones. Presidente: SANTANA APARICIO VICENTE. Consejero: PERENNIUS SL;SANTANA APARICIO VICENTE. Cons.Del.Sol: SANTANA APARICIO VICENTE. Datos registrales. T 22908 , F 90, S 8, H M 245290, I/A 38 (14.02.11).

19/10/2010 Sec. I Declaración de unipersonalidad Madrid
Madrid-386864

Declaración de unipersonalidad — 19/10/2010

Declaración de unipersonalidad. Socio único: PERENNIUS SL. Datos registrales. T 22908 , F 90, S 8, H M 245290, I/A 36 ( 6.10.10).

19/10/2010 Sec. I Declaración de unipersonalidad Madrid
Madrid-386864

Declaración de unipersonalidad — 19/10/2010

Declaración de unipersonalidad. Socio único: PERENNIUS SL. Datos registrales. T 22908 , F 90, S 8, H M 245290, I/A 36 ( 6.10.10).

14/10/2010 Sec. I Reducción de capital Madrid
Madrid-381519

Reducción de capital — 14/10/2010

Reducción de capital. Importe reducción: 281.958,00 Euros. Resultante Suscrito: 27.913.440,00 Euros. Reducción de capital. Importe reducción: 1.222.878,00 Euros. Resultante Suscrito: 26.690.562,00 Euros. Datos registral...

07/06/2010 Sec. I Otros conceptos: SE SUBSANA LA ESCRITURA AUTORIZADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2 Madrid
Madrid-224981

Otros conceptos: se subsana la escritura autorizada el 13 de diciembre de 2 — 07/06/2010

Otros conceptos: SE SUBSANA LA ESCRITURA AUTORIZADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2.006, POR EL NOTARIO DE MADRID, D. MANUEL MARTEL DIAZ-LLANOS,CON EL Nº 2.869, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 22&, EN EL SENTIDO DE QUE EL ARTICULO QUE...

07/06/2010 Sec. I Otros conceptos: SE SUBSANA LA ESCRITURA AUTORIZADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2 Madrid
Madrid-224981

Otros conceptos: se subsana la escritura autorizada el 13 de diciembre de 2 — 07/06/2010

Otros conceptos: SE SUBSANA LA ESCRITURA AUTORIZADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2.006, POR EL NOTARIO DE MADRID, D. MANUEL MARTEL DIAZ-LLANOS,CON EL Nº 2.869, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 22&, EN EL SENTIDO DE QUE EL ARTICULO QUE...

19/01/2010 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-18057

Reelecciones — 19/01/2010

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 22908 , F 89, S 8, H M 245290, I/A 33 ( 4.01.10).

19/01/2010 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-18057

Reelecciones — 19/01/2010

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 22908 , F 89, S 8, H M 245290, I/A 33 ( 4.01.10).

20/11/2009 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-486673

Revocaciones — 20/11/2009

Revocaciones. Apoderado: PEREZ BUSTAMANTE LADISLAO JAVIER. Datos registrales. T 22908 , F 89, S 8, H M 245290, I/A 31 (11.11.09).

20/11/2009 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-486674

Ceses/dimisiones — 20/11/2009

Ceses/Dimisiones. Consejero: DE OTTO ROMEO CARLOS. Datos registrales. T 22908 , F 89, S 8, H M 245290, I/A 32 (11.11.09).

17/09/2009 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-399382

Ceses/dimisiones — 17/09/2009

Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ BUSTAMANTE LADISLAO. Cons.Del.Sol: PEREZ BUSTAMANTE LADISLAO. Datos registrales. T 22908 , F 89, S 8, H M 245290, I/A 30 ( 4.09.09).

17/09/2009 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-399382

Ceses/dimisiones — 17/09/2009

Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ BUSTAMANTE LADISLAO. Cons.Del.Sol: PEREZ BUSTAMANTE LADISLAO. Datos registrales. T 22908 , F 89, S 8, H M 245290, I/A 30 ( 4.09.09).

30/01/2009 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-52505

Reelecciones — 30/01/2009

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 22908 , F 89, S 8, H M 245290, I/A 29 (21.01.09). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 20 Viernes 30 de enero de 2009 Pág. 6196 cve...

30/01/2009 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-52505

Reelecciones — 30/01/2009

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 22908 , F 89, S 8, H M 245290, I/A 29 (21.01.09). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 20 Viernes 30 de enero de 2009 Pág. 6196 cve...