Actos destacados
Reelecciones — 12/12/2019
Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 6360 , F 181, S 8, H SE102814, I/A 17 ( 2.12.19).
Reelecciones — 31/10/2018
Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 6360 , F 180, S 8, H SE102814, I/A 16 (23.10.18).
Ceses/dimisiones — 12/12/2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERVILTA SOCIEDAD LIMITADA. Presidente: FERVILTA SOCIEDAD LIMITADA. Cons.Del.Sol: FERVILTA SOCIEDAD LIMITADA. Consejero: ENFEVI INVERSIONES SL. Cons.Del.Sol: ENFEVI INVERSIONES SL. Consejero...
Ceses/dimisiones — 15/09/2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: SOLIS MARTINEZ CAMPOS FERNANDO. Vicepresid.: SOLIS MARTINEZ CAMPOS FERNANDO. Cons.Del.Sol: SOLIS MARTINEZ CAMPOS FERNANDO. Nombramientos. Consejero: DEHESA DEL MESTO SL. Vicepresid.: DEHESA...
Ceses/dimisiones — 24/06/2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: BORDAS SANCHEZ PASTOR CARLOS. Datos registrales. T 5923 , F 184, S 8, H SE102814, I/A 12 (15.06.16).
Revocaciones — 11/05/2016
Revocaciones. Apoderado: FAYULA GONZALEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 5923 , F 183, S 8, H SE102814, I/A 11 ( 4.05.16).
Nombramientos — 06/04/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: MIRO BERENGUER JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 5923 , F 183, S 8, H SE102814, I/A 10 (28.03.16).
Ceses/dimisiones — 04/04/2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CONCESIONARIOS DEL SUR SA. Nombramientos. Consejero: FERVILTA SOCIEDAD LIMITADA. Presidente: FERVILTA SOCIEDAD LIMITADA. Cons.Del.Sol: FERVILTA SOCIEDAD LIMITADA. Consejero: SOLIS MARTINEZ...
Nombramientos — 23/03/2016
Nombramientos. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 5923 , F 180, S 8, H SE102814, I/A 8 (15.03.16).
Revocaciones — 05/02/2016
Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ CANDAU ALVARO. Apo.Manc.: BENITEZ RINCON DAVID;BENITEZ RINCON DAVID. Apo.Sol.: BENITEZ RINCON DAVID. Datos registrales. T 5923 , F 180, S 8, H SE102814, I/A 7 (27.01.16).
Nombramientos — 08/09/2015
Nombramientos. Apoderado: FAYULA GONZALEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 5923 , F 180, S 8, H SE102814, I/A 6 (31.08.15).
Nombramientos — 27/03/2015
Nombramientos. Apo.Manc.: MIRO BERENGUER JOSE ANTONIO;ALCALA GARCIA RAFAEL;BENITEZ RINCON DAVID. Apo.Sol.: MIRO BERENGUER JOSE ANTONIO;ALCALA GARCIA RAFAEL;BENITEZ RINCON DAVID. Datos registrales. T 5923 , F 178, S 8, H...
Nombramientos — 27/03/2015
Nombramientos. Apo.Manc.: YORQUEZ RAMIREZ MANUEL;ALCALA GARCIA RAFAEL. Apo.Sol.: YORQUEZ RAMIREZ MANUEL;ALCALA GARCIA RAFAEL. Datos registrales. T 5923 , F 179, S 8, H SE102814, I/A 5 (17.03.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REG...
Nombramientos — 28/11/2014
Nombramientos. Apo.Manc.: ALCALA GARCIA RAFAEL;BENITEZ RINCON DAVID. Datos registrales. T 5923 , F 177, S 8, H SE102814, I/A 3 (18.11.14).
Nombramientos — 20/11/2014
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ CANDAU ALVARO. Datos registrales. T 5923 , F 176, S 8, H SE102814, I/A 2 (10.11.14).
Constitución — 24/10/2014
Constitución. Comienzo de operaciones: 10.10.14. Objeto social: La organización y explotación de toda clase de industria y negocios que guarden relación con la representación, distribución y venta de vehículos, camiones...