Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 14 tarjetas
03/12/2019 Sec. I Revocaciones Jaén
Jaén-499014

Revocaciones — 03/12/2019

Revocaciones. Apoderado: GUTIERREZ PEREZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 493 , F 156, S 8, H J 11176, I/A 24 (27.11.19). https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

20/11/2019 Sec. I Nombramientos Jaén
Jaén-479482

Nombramientos — 20/11/2019

Nombramientos. Auditor: ABA CONSULTORES Y AUDITORES DE CUENTAS SL. Datos registrales. T 493 , F 156, S 8, H J 11176, I/A 23 (14.11.19). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 223 Miércoles 20 de noviembre de 2019 P...

10/01/2018 Sec. I Nombramientos Jaén
Jaén-12543

Nombramientos — 10/01/2018

Nombramientos. Apoderado: JOSE LUIS AGUILERA GONZALEZ. Gerente: JOSE LUIS AGUILERA GONZALEZ. Datos registrales. T 493 , F 155, S 8, H J 11176, I/A 22 ( 3.01.18).

21/06/2017 Sec. I Nombramientos Jaén
Jaén-257029

Nombramientos — 21/06/2017

Nombramientos. Auditor: FERNANDEZ PUERTAS VICTOR MANUEL. Aud.Supl.: ABA CONSULTORES Y AUDITORES DE CUENTAS SL. Datos registrales. T 493 , F 155, S 8, H J 11176, I/A 21 (14.06.17).

23/06/2016 Sec. I Cambio de domicilio social Jaén
Jaén-265177

Cambio de domicilio social — 23/06/2016

Cambio de domicilio social. C/ CERRO DE LOS ALCARAVANES 3 (ANDUJAR). Datos registrales. T 493 , F 155, S 8, H J 11176, I/A 20 (17.06.16).

13/05/2014 Sec. I Ampliación de capital Jaén
Jaén-200922

Ampliación de capital — 13/05/2014

Ampliación de capital. Capital: 46.272,00 Euros. Resultante Suscrito: 377.406,00 Euros. Datos registrales. T 493 , F 155, S 8, H J 11176, I/A 19 ( 6.05.14).

21/08/2013 Sec. I Nombramientos Jaén
Jaén-370995

Nombramientos — 21/08/2013

Nombramientos. Apoderado: MARIA DOLORES GONZALEZ MESA. Datos registrales. T 493 , F 154, S 8, H J 11176, I/A 18 (13.08.13).

29/01/2013 Sec. I Ampliación de capital Jaén
Jaén-43939

Ampliación de capital — 29/01/2013

Ampliación de capital. Capital: 90.134,00 Euros. Resultante Suscrito: 331.134,00 Euros. Datos registrales. T 493 , F 154, S 8, H J 11176, I/A 17 (22.01.13).

14/12/2011 Sec. I Revocaciones Jaén
Jaén-495971

Revocaciones — 14/12/2011

Revocaciones. Apoderado: JOSE LUIS AGUILERA GONZALEZ. Datos registrales. T 493 , F 154, S 8, H J 11176, I/A 15 ( 1.12.11).

14/12/2011 Sec. I Cambio de objeto social Jaén
Jaén-495972

Cambio de objeto social — 14/12/2011

Cambio de objeto social. Operador de transporte nacional e internacional -transitorio, almacenista distribuidor, agencia de transportes-. Transporte de mercancías por carretera, nacional e internacional. Arrendamiento d...

07/11/2011 Sec. I Ampliación de capital Jaén
Jaén-441028

Ampliación de capital — 07/11/2011

Ampliación de capital. Capital: 180.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 241.000,00 Euros. Datos registrales. T 303 , F 161, S 8, H J 11176, I/A 14 (26.10.11).

14/10/2011 Sec. I Revocaciones Jaén
Jaén-407685

Revocaciones — 14/10/2011

Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ CASTAÑO ROQUE. Datos registrales. T 303 , F 160, S 8, H J 11176, I/A 12 ( 5.10.11).

14/10/2011 Sec. I Nombramientos Jaén
Jaén-407686

Nombramientos — 14/10/2011

Nombramientos. Apoderado: GUTIERREZ PEREZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 303 , F 160, S 8, H J 11176, I/A 13 ( 5.10.11).

14/06/2010 Sec. I Revocaciones Jaén
Jaén-235604

Revocaciones — 14/06/2010

Revocaciones. Apoderado: EXPOSITO SANTAMARIA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 303 , F 160, S 8, H J 11176, I/A 10 ( 2.06.10).